NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED

NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01538209
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    • Großhandel mit Erdöl und Erdölprodukten (46711) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Energy House
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    R.P.D. GAS LIMITED10. Feb. 198810. Feb. 1988
    R. P. D. GAS SUPPLIES EQUIPMENT LIMITED12. Jan. 198112. Jan. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Aug. 2021

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Steven Adrian Walmsley als Geschäftsführer am 15. Juli 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Laura Harper als Geschäftsführer am 15. Juli 2021

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Mai 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Aug. 2020

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 21. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SALISBURY, Christopher
    Energy House
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Sekretär
    Energy House
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    BritishAccountant71904110003
    ILLINGWORTH, David Stephen
    Woodside
    Greystone Plain Lane Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodside
    Greystone Plain Lane Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishOperations Manager13110120001
    ILLINGWORTH, Edward
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector187510890001
    ILLINGWORTH, Howard Seth
    Ashcroft Rowden Lane
    Hampsthwaite
    HG3 2HR Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ashcroft Rowden Lane
    Hampsthwaite
    HG3 2HR Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishChairman13110110001
    ILLINGWORTH, James
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishUk187512910001
    ILLINGWORTH, Stuart
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector187511850001
    BAILEY, John
    21 The Croft
    Kirby Hill
    YO51 9YA Boroughbridge
    North Yorkshire
    Sekretär
    21 The Croft
    Kirby Hill
    YO51 9YA Boroughbridge
    North Yorkshire
    BritishCompany Director58501700001
    ILLINGWORTH, Howard Seth
    Ashcroft Rowden Lane
    Hampsthwaite
    HG3 2HR Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    Ashcroft Rowden Lane
    Hampsthwaite
    HG3 2HR Harrogate
    North Yorkshire
    British13110110001
    MILNOR, Lisa Rachael
    Goal Farm
    Hellifield
    BD23 4JR Skipton
    North Yorkshire
    Sekretär
    Goal Farm
    Hellifield
    BD23 4JR Skipton
    North Yorkshire
    BritishFinancial Director53306760001
    STANFORD, Thomas Martin
    17 Bluebell Meadow
    HG3 2HF Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    17 Bluebell Meadow
    HG3 2HF Harrogate
    North Yorkshire
    British40126480002
    BAILEY, John
    21 The Croft
    Kirby Hill
    YO51 9YA Boroughbridge
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    21 The Croft
    Kirby Hill
    YO51 9YA Boroughbridge
    North Yorkshire
    BritishCompany Director58501700001
    HARPER, Laura
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Energy House
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector187513210001
    ILLINGWORTH, Mark Richard
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hampsthwaite Head
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSales Director13110130002
    MILNOR, Lisa Rachael
    Goal Farm
    Hellifield
    BD23 4JR Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Goal Farm
    Hellifield
    BD23 4JR Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Director53306760001
    WALMSLEY, Steven Adrian
    The Gables
    Minskip Road, Boroughbridge
    YO51 9HY York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Gables
    Minskip Road, Boroughbridge
    YO51 9HY York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManager33287040002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Howard Seth Illingworth
    Energy House
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    22. Apr. 2017
    Energy House
    Hampsthwaite
    HG3 2HT Harrogate
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat NORTHERN LPG SUPPLIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 2011
    Geliefert am 29. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Fixed charge
    Erstellt am 02. Mai 2000
    Geliefert am 13. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The assets listed in the invoices shown on the form M395 and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC,Royscot Leasing LTD, Royscot Industrial Leasingltd, Royscot Commercial Leasing LTD, Royscot Spa Leasing LTD
    Transaktionen
    • 13. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 14. Apr. 2000
    Geliefert am 19. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The following assets as more particularly described in various invoices (please refer to form 395 for full details) and the proceeds and products thereof.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC Royscot Leasing Limited Royscot Industrial Leasing Limited Royscotcommercial Leasing Limited Royscot Spa Leasinglimited
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 26. Apr. 1999
    Geliefert am 01. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the invoices specified in the charge and all policies of insurance warranties guarantees and other contracts in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Leasing LTD.
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    Transaktionen
    • 01. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 23. Okt. 1998
    Geliefert am 27. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property as listed on schedule to form 395 and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts now in force or during the currency of this security entered into in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Leasing Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 24. März 1998
    Geliefert am 28. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property as more particularly described in various invoices annexed to the fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC , Royscot Leasing Limited, Royscot Industrial Leasing Limited, Royscotcommercial Leasing Limited and Royscot Spa Leasing Limited
    Transaktionen
    • 28. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 29. Aug. 1997
    Geliefert am 03. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various invoices as specified in schdule to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Spa Leasing LTD
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Commercial Leasing LTD
    • Royscot Industrial Leasing LTD
    • Royscot Leasing LTD
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 29. Apr. 1997
    Geliefert am 02. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property as listed on the schedule attached to form 395 being: invoice number 73909, 73994, 74026, 74057, 74110, 74089 and 74311, supplier gas power services limited (and others as defined on form 395) and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance.... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Leasing Limited
    Transaktionen
    • 02. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 28. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property listed on the schedule to form M395 and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC, Royscot Leasing LTD, Royscot Industrial Leasing LTD,
    • Royscot Commercial Leasing LTD, Royscot Spa Leasing LTD,
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 27. Juni 1996
    Geliefert am 13. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property listed on the schedule attached to the form 395 and the proceeds and products thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 02. Apr. 1996
    Geliefert am 11. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The assets as described in the schedule attached to the form 395 and the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance warranties guarantees and other contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 22. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The following property being the assets k/a :- 4 x 2250 ltr vessels serial no PV11219 550/6362/5 lg 1275A. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge,
    Erstellt am 05. Jan. 1995
    Geliefert am 06. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property, comprising various invoice notes dated between 10TH june 1994 to 30TH september 1994, please see schedule for full details. And the proceeds and products thereof and the benefit of all policies of insurance ,warranties , guarantees and other contracts now or in force or during the currency of this security entered into in respect of the property, please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC,
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge .
    Erstellt am 31. Aug. 1994
    Geliefert am 20. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 x 600KG lpg vessel serial no S18887, 2X 1750KG lpg vessel serial no S21257, S21258, 5X 600KG lpg vessel serial no S18879, S18882, S18883, S18885. S18948. please see doc for further details of equipment ,and details.
    Berechtigte Personen
    • Royscot Trust PLC.
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 09. Aug. 1990
    Geliefert am 21. Aug. 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 26. Apr. 1983
    Geliefert am 27. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1983Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0