COMMUNITIE.COM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COMMUNITIE.COM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01542701 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COMMUNITIE.COM LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich COMMUNITIE.COM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Stanley Gibbons Limited 399 Strand WC2R 0LX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COMMUNITIE.COM LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COMMUNITIE LIMITED | 04. Apr. 2000 | 04. Apr. 2000 |
| BLUEPRIME LIMITED | 02. Feb. 1981 | 02. Feb. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMMUNITIE.COM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COMMUNITIE.COM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Andrew Millar Heddle als Geschäftsführer am 08. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony Michael Gee als Direktor am 08. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 31. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Keith Andrew Millar Heddle als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Henley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COMMUNITIE.COM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURKIS, Richard Kenneth | Sekretär | Chiswell House Shernden Lane Marsh Green TN8 5PR Edenbridge Kent | British | 50467140001 | ||||||
| GEE, Anthony Michael | Geschäftsführer | C/O Stanley Gibbons Limited 399 Strand WC2R 0LX London | United Kingdom | British | 181780820001 | |||||
| PURKIS, Richard Kenneth | Geschäftsführer | C/O Stanley Gibbons Limited 399 Strand WC2R 0LX London | England | British | 50467140001 | |||||
| PANDIT, Arvind Jivanlal | Sekretär | 33 Oak Vale West End SO30 3SE Southampton Hampshire | British | 4791360001 | ||||||
| DUNNINGHAM, Timothy | Geschäftsführer | Avranches Farm La Ruette D`Avranches St Lawrence JE3 1GJ Jersey Channel Islands | Jersey | British | 58978030001 | |||||
| FRASER, Paul Ian | Geschäftsführer | 222 Cheltenham Road BS6 5QU Bristol Avon | British | 5342100001 | ||||||
| GRODECKI, Antony Richard Jan | Geschäftsführer | The Maltings Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | 42800860002 | ||||||
| HALL, Michael Robert Montague | Geschäftsführer | Doyle Court Doyle Road St Peter Port GY1 1RD Guernsey Channel Islands | British | 74643910002 | ||||||
| HEDDLE, Keith Andrew Millar | Geschäftsführer | C/O Stanley Gibbons Limited 399 Strand WC2R 0LX London | England | British | 164474410001 | |||||
| HENLEY, Mark David | Geschäftsführer | C/O Stanley Gibbons Limited 399 Strand WC2R 0LX London | England | British | 52315890005 | |||||
| MCQUILLAN, Anthony Michael | Geschäftsführer | Church Lodge Station Road Wrington BS40 5LG Bristol Avon | Irish | 22631310001 | ||||||
| PANDIT, Arvind Jivanlal | Geschäftsführer | 33 Oak Vale West End SO30 3SE Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 4791360001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COMMUNITIE.COM LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Gibbons Limited | 06. Apr. 2016 | Strand WC2R 0LX London 399 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COMMUNITIE.COM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 05. Mai 1994 Geliefert am 12. Mai 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Nov. 1989 Geliefert am 15. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2B, ringwood industrial park, christchurch road, ringwood, hampshire title no. Hp 215662. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Nov. 1989 Geliefert am 15. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2A, ringwood industrial estate ringwood, hampshire. Title no. Hp 222022. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Sept. 1989 Geliefert am 22. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture deed | Erstellt am 11. Juni 1986 Geliefert am 17. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or the companies (as defined) to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben (Please see doc M24 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 29. Okt. 1984 Geliefert am 16. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Juni 1982 Geliefert am 12. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,750,000 and all other monies due or to become due from stanley gibbons international limited under the terms of a share sale agreement dtd 25.6.82 | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill & debts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery (see doc M21 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee debenture | Erstellt am 25. Juni 1982 Geliefert am 09. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0