MOCOR LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MOCOR LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01543832 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MOCOR LIMITED?
- (5143) /
Wo befindet sich MOCOR LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tower 12 18/22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MOCOR LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROCOM LIMITED | 14. Sept. 2006 | 14. Sept. 2006 |
| ROCOM GROUP LIMITED | 22. März 1996 | 22. März 1996 |
| ROCOM LIMITED | 20. Nov. 1986 | 20. Nov. 1986 |
| ROCOM SYSTEMS LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| DEWFORD LIMITED | 06. Feb. 1981 | 06. Feb. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOCOR LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MOCOR LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 13 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Hollins Mount Hollins Lane Bury BL9 8DG zum Tower 12 18/22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ am 10. Jan. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juni 2015 | 18 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juni 2014 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juni 2013 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Carlton House 16-18 Albert Square Manchester M2 5PE* am 06. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Juni 2012 | 11 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 3 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Nexus Solicitors Carlton Hoouse 16-18 Albert Square Manchester M2 5PE United Kingdom* am 13. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2010 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Rocom Limited Agecroft Road Pendlebury Manchester M27 8SB United Kingdom* am 11. Okt. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2010 bis 31. Aug. 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed rocom LIMITED\certificate issued on 02/10/10 | 4 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Saul Loggenberg als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Gee als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MOCOR LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOGGENBERG, Saul | Geschäftsführer | 18/22 Bridge Street Spinningfields M3 3BZ Manchester Tower 12 | South Africa | British | 154392440001 | |||||
| GEE, Christopher Philip | Sekretär | Agecroft Road Pendlebury M27 8SB Manchester Rocom Limited United Kingdom | British | 137663760001 | ||||||
| HAYWARD, John William | Sekretär | 25 Castellain Mansions Castellain Road W9 1HE London | British | 111473800001 | ||||||
| HODGSON, Angela Michele | Sekretär | 328 Wakefield Road HD5 8DQ Huddersfield West Yorkshire | British | 97385330001 | ||||||
| LINES, Doreen | Sekretär | Stone Court 37 Spofforth Hill LS22 6SF Wetherby West Yorkshire | British | 10299250001 | ||||||
| PHILLIPS, Elaine Lesley | Sekretär | 4 East Parade YO31 7YJ York North Yorkshire | British | 39032080002 | ||||||
| WEBB, Forbes Waddington | Sekretär | 7 Firle Grange BN25 2HD Seaford East Sussex | British | 84060000001 | ||||||
| WEST, Michael David | Sekretär | 6 Woodside Place Wildhill Road Woodside AL9 6DN Hatfield Hertfordshire | British | 112844320001 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| BUCKLEY, James Peter | Geschäftsführer | Love Lane House Love Lane South Cave HU15 2AA Brough East Yorkshire | British | 81874780001 | ||||||
| CAMFIELD, Jain Anne | Geschäftsführer | Pikes Head Lodge Cattle Lane Aberford LS25 3BH Leeds West Yorkshire | British | 54901130001 | ||||||
| CARTER, Richard Michael | Geschäftsführer | Nine Acres, 78 Manchester Road SK9 2JY Wilmslow Cheshire | British | 6602780002 | ||||||
| CHARNOCK, Christopher Gerard | Geschäftsführer | 6 Coverdale Close Whittle Hall WA5 3DH Warrington Cheshire | England | British | 50246180001 | |||||
| CUNNINGHAM, John | Geschäftsführer | Agecroft Road Pendlebury M27 8SB Manchester Rocom Limited United Kingdom | England | English | 69469980002 | |||||
| GIBBARD, Peter William | Geschäftsführer | 7 St Johns Crescent YO3 7QP York | British | 10401960003 | ||||||
| GILLINGS, Paula | Geschäftsführer | 83 Grove Lane SK8 7LZ Cheadle Hulme Stockport | England | British | 106635250002 | |||||
| GRANT, Anthony Ernest | Geschäftsführer | 63 Old Park Road LS8 1JB Leeds | United Kingdom | British | 9952930001 | |||||
| HAMBLY, Philip | Geschäftsführer | 7 Crofters Green Killinghall HG3 2GY Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 102768960001 | |||||
| HARRISON, Stephen John | Geschäftsführer | 2 Templar Gardens LS22 7TG Wetherby West Yorkshire | British | 10375510001 | ||||||
| KEAN, Scott Charles | Geschäftsführer | 39 Lawrence Moorings CM21 9PE Sawbridgeworth Hertfordshire | British | 80444700003 | ||||||
| KEITH, Alan Michael | Geschäftsführer | 108 Churchfields Shoeburyness SS3 8TN Southend On Sea Essex | British | 36279010002 | ||||||
| LINES, Doreen | Geschäftsführer | Stone Court 37 Spofforth Hill LS22 6SF Wetherby West Yorkshire | British | 10299250001 | ||||||
| LISTER, Alex | Geschäftsführer | 3 Lascelles Grove HG2 0LB Harrogate North Yorkshire | British | 97385250002 | ||||||
| LOVELL, David John | Geschäftsführer | Furrowfield St Johns Road Scotton HG5 9HT Knaresborough North Yorkshire | British | 57944900001 | ||||||
| MASSEY, Raymond John | Geschäftsführer | 329 Benfleet Road SS7 1PW South Benfleet Essex | United Kingdom | British | 44018860001 | |||||
| NICOL, Richard Mcpike | Geschäftsführer | White Smithy Barn Paradise Lane LS24 9NJ Tadcaster North Yorkshire | British | 74213720001 | ||||||
| NIMAN, Julian Howard | Geschäftsführer | Agecroft Road Pendlebury M27 8SB Manchester Rocom Limited United Kingdom | United Kingdom | English | 6602760004 | |||||
| NORMAN, Stephen Malcolm | Geschäftsführer | Flat 3 27 Rutland Drive HG1 2NS Harrogate North Yorkshire | British | 116497770001 | ||||||
| OLD, Robert Lee | Geschäftsführer | Kiln Hill Linton Lane Linton LS22 4HL Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 10299260001 | |||||
| OLD, Thelma Elizabeth | Geschäftsführer | Kiln Hill Linton Lane Linton LS22 4HL Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 198820170001 | |||||
| PHILLIPS, Elaine Lesley | Geschäftsführer | 4 East Parade YO31 7YJ York North Yorkshire | British | 39032080002 | ||||||
| STRAIN, John David | Geschäftsführer | 14 Thorp Arch Mill Thorp Arch LS23 7DZ Wetherby West Yorkshire | England | British | 54822630001 | |||||
| TUNESI, Gregory James Edmund Ernest | Geschäftsführer | 60 Duchy Road HG1 2EZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 38920830002 | |||||
| TUPMAN, Timothy Alexander | Geschäftsführer | Highlands Berden CM23 1AB Bishops Stortford Hertfordshire | England | British | 67184090006 | |||||
| WEBB, Forbes Waddington | Geschäftsführer | 7 Firle Grange BN25 2HD Seaford East Sussex | British | 84060000001 |
Hat MOCOR LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. März 2009 Geliefert am 02. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating charge | Erstellt am 24. März 2009 Geliefert am 02. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. März 2009 Geliefert am 31. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 2008 Geliefert am 05. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. März 2007 Geliefert am 09. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The warehouse and communications building, separate office building and gatehouse thorpe arch trading estate wetherby. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Aug. 2006 Geliefert am 23. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as thorp arch trading estate wetherby west yorkshire t/n's WYK465257 WYK370239 and WYK754664. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 2006 Geliefert am 23. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 29. Feb. 2000 Geliefert am 18. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in respect of the service provider agreement dated 29 february 2000 | |
Kurze Angaben First fixed charge all claims in intellectual property and goodwill in the subscriber base. All debts and other debts standing to the credit of rocom group limited in the account name of "rocom group/vodafone designated account" withlloyds tsb bank PLC or any other bank. Floating charge to the remainder of the subscriber base. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Mai 1997 Geliefert am 18. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,091,741 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land lying to the north of avenue c east thorp arch wetherby west yorkshire t/n WYK370529. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 1986 Geliefert am 28. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MOCOR LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0