ACT OVERSEAS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ACT OVERSEAS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01543895 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ACT OVERSEAS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ACT OVERSEAS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ACT OVERSEAS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BIS INTERNATIONAL LIMITED | 09. Feb. 1981 | 09. Feb. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACT OVERSEAS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ACT OVERSEAS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 15 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. Feb. 2017 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 60 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Juli 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mr Johannes Jacobus Olivier als Direktor am 20. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Paul Woodward als Geschäftsführer am 20. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Paul Woodward als Direktor am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sanjay Patel als Geschäftsführer am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr John Van Harken als Direktor am 31. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Mary Collins als Geschäftsführer am 31. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Elizabeth Mary Collins als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Director Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ACT OVERSEAS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKEN, John Van | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | American | 183654340001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| OLIVIER, Johannes Jacobus | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | South African | 199516920001 | |||||||||
| BAINS, Gurbinder | Sekretär | Kingston Road UB2 4AP Southall 36 Middlesex United Kingdom | Other | 138753780001 | ||||||||||
| BICHEMO, Tracey Lynne | Sekretär | Flat E 9 Longridge Road SW5 9SB London | British | 16560470002 | ||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| NASH, Andrew | Sekretär | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street |
| 149977350001 | ||||||||||
| COLLINS, Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| COPELAND, Philip Robert | Geschäftsführer | Crofton Sheldon Road Ickford HP18 9HY Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 44954570001 | |||||||||
| EVANS, Robert Owen | Geschäftsführer | Field House Ashow CV8 2LE Kenilworth Warwickshire | British | 57011000002 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue WD17 4NU Watford 51 Hertfordshire England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| FLANAGAN, Andrew Henry | Geschäftsführer | 75 Drymen Road Bearsden G61 2RH Glasgow | British | 42787120001 | ||||||||||
| GORDON, George Michael Winston | Geschäftsführer | 5 Englehurst AL5 5SQ Harpenden Hertfordshire | British | 37797170001 | ||||||||||
| GRAHAM, George Malcolm Roger | Geschäftsführer | Gaston House Gaston Green Little Hallingbury CM22 7QS Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 36314420001 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| HELSBY, Frank Peter | Geschäftsführer | 27 Park Green Great Bookham KT23 3NL Leatherhead Surrey | England | British | 34237710003 | |||||||||
| MCMAHON, Jasper Philip | Geschäftsführer | Ground Floor Flat 33 Warrington Crescent W9 1EJ London | England | British | 45080250003 | |||||||||
| OLDERSHAW, Peter Alan | Geschäftsführer | Wellesbourne 80 Newfield Road West Hagley DY9 0HY Stourbridge West Midlands | British | 2546430001 | ||||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| WHITTY, Brian Howard | Geschäftsführer | Ruxley House Rowney Green Lane Rowney Green B48 7QF Alvechurch Worcestershire | British | 36622750002 | ||||||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 100885620001 | |||||||||
| MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Kingdom Street Paddington W2 6BL London 1 | 82836510002 |
Hat ACT OVERSEAS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ACT OVERSEAS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0