MISYS KBS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MISYS KBS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01545543 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MISYS KBS LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MISYS KBS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MISYS KBS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KINDLE BANKING SYSTEMS LIMITED | 17. Okt. 1995 | 17. Okt. 1995 |
| ACT BANKING SYSTEMS (U.K.) LIMITED | 14. Apr. 1994 | 14. Apr. 1994 |
| ACT KINDLE (U.K.) LIMITED | 04. Juni 1992 | 04. Juni 1992 |
| KINDLE LIMITED | 29. Nov. 1985 | 29. Nov. 1985 |
| TRIPLE A SYSTEMS LIMITED | 25. Apr. 1983 | 25. Apr. 1983 |
| M.A. SOFTWARE LIMITED | 17. März 1982 | 17. März 1982 |
| M.A. SYSTEMS (LONDON) LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| PEACEPAR LIMITED | 13. Feb. 1981 | 13. Feb. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MISYS KBS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MISYS KBS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Mai 2016 | 28 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Paul Woodward als Direktor am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sanjay Patel als Geschäftsführer am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Van Harken als Direktor am 31. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Mary Collins als Geschäftsführer am 31. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Elizabeth Mary Collins als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Director Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanna Hawkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Sanjay Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Joanna Marageret Hawkes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bijal Patel als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Edward Timothy Homer am 20. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Bijal Mahendra Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MISYS KBS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKEN, John Van | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | American | 183654340001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 100885620001 | |||||||||
| BRAIN, Sarah Elizabeth Highton | Sekretär | Portwood Cottage The Street Warninglid Haywards Heath RH17 5SZ West Sussex No 1 England England | 146638700001 | |||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| NASH, Andrew | Sekretär | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| WILSON, Kevin Michael | Sekretär | Strauss Road Chiswick W4 1DL London 10 | Other | 138835080001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Kingdom Street Paddington W2 6BL London One United Kingdom |
| 170449080001 | ||||||||||
| CLANCY, Conall Patrick | Geschäftsführer | 3 Homelee IRISH Ballsbridge Dublin 4 Ireland | Irish | 37703500001 | ||||||||||
| COLLINS, Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| COLWELL, John | Geschäftsführer | 37 Linden Grove KT12 1EY Walton-On-Thames Surrey | British | 98195430003 | ||||||||||
| DERRER, Andrew Jan | Geschäftsführer | South Lodge Caversfield OX27 8TH Bicester Oxon | England | British | 121601200001 | |||||||||
| EVANS, Robert Owen | Geschäftsführer | Field House Ashow CV8 2LE Kenilworth Warwickshire | British | 57011000002 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue WD17 4NU Watford 51 Hertfordshire England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| HUGHES, Kevin Gerard | Geschäftsführer | 31 Cromwell Avenue Billericay CM12 OAG Essex | United Kingdom | British | 173214140001 | |||||||||
| KILDUFF, Martin Anthony | Geschäftsführer | 21 Ailesbury Drive Bailsbridge Dublin 4 Ireland | Irish | 32778090001 | ||||||||||
| MEANY, Patrick Declan | Geschäftsführer | 23 Calderwood Road Drumcondra Dublin 9 Ireland | Irish | 82121570001 | ||||||||||
| NAGLE, Kieran Matthew | Geschäftsführer | Rustic Lodge Carrick Hill Portmarnock Co Dublin Ireland | Irish | 43947240001 | ||||||||||
| NAGLE, Kieran Matthew | Geschäftsführer | Rustic Lodge Carrick Hill Portmarnock Co Dublin Ireland | Irish | 43947240001 | ||||||||||
| NOCTOR, Desmond James | Geschäftsführer | 37 Bourne Avenue SL4 3JP Windsor Berkshire | Irish | 32778100001 | ||||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| STOKES, Mark | Geschäftsführer | 28 Gilford Park Sandymount Dublin 4 Ireland Ireland | Irish | 82121580001 | ||||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | 25 Jordan Road B75 5AB Sutton Coldfield West Midlands | British | 1442450001 | ||||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom |
| 158141250001 |
Hat MISYS KBS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Jan. 1987 Geliefert am 28. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's book debts and other receivables present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 1986 Geliefert am 18. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of collateral debenture | Erstellt am 26. Mai 1986 Geliefert am 16. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from kindle group limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben By way of floating security all the company's undertaking and assets present and future including uncalled capital for the time being & goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of chattel mortgage | Erstellt am 26. Mai 1986 Geliefert am 16. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all the property & assets listed in doc M29. (See doc M29 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 19. Juni 1985 Geliefert am 03. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the M. A. bereau services LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoerver both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 19. Juni 1985 Geliefert am 03. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the M. A. systems LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital fot the time being and goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MISYS KBS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0