CRISP COMPUTING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCRISP COMPUTING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01547979
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CRISP COMPUTING LIMITED?

    • (7222) /

    Wo befindet sich CRISP COMPUTING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    6th Floor 4 Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CRISP COMPUTING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CRISP GROUP PLC18. Mai 199818. Mai 1998
    CRISP COMPUTING LIMITED09. Jan. 198509. Jan. 1985
    CROWNSTAR DEVELOPMENTS LIMITED02. März 198102. März 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRISP COMPUTING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für CRISP COMPUTING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Paul Terence Sweeny am 17. Dez. 2010

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pegasus House Kings Business Park Liverpool Road Prescot Merseyside L34 1PJ am 26. Aug. 2010

    1 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. März 2010

    Kapitalaufstellung am 26. März 2010

    • Kapital: GBP 122,990.1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Jeffrey Chittenden als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jeffrey Chittenden als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    11 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    17 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CRISP COMPUTING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHEFFIELD, Anne Louise
    The Design Works
    93 - 99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    Flat 15
    Sekretär
    The Design Works
    93 - 99 Goswell Road
    EC1V 7EY London
    Flat 15
    Other134678250001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish44173560008
    SWEENY, Paul Terence
    98 Park Street
    W1K 6NZ London
    Flat 4
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    98 Park Street
    W1K 6NZ London
    Flat 4
    United Kingdom
    United KingdomBritish140303320002
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Sekretär
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    BIRKETT, Timothy Lloyd
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    17 Padstow Drive
    Bramhall
    SK7 2HU Stockport
    Cheshire
    British99698140001
    CROFT, Christopher Rendell
    2 Grimston Road
    SW6 3QP London
    Sekretär
    2 Grimston Road
    SW6 3QP London
    British55143000001
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    Sekretär
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    British79149580001
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    Sekretär
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    British97303290001
    WHITMORE, Gerald Michael
    18 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    Sekretär
    18 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    British41061870001
    UU SECRETARIAT LIMITED
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    Sekretär
    Haweswater House, Lingley Mere Business Park
    Lingley Green Avenue Great Sankey
    WA5 3LP Warrington
    94063410003
    AMOS, David Stephen
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    6 Acre Lane
    Webheath
    B97 5WN Redditch
    Worcestershire
    British65186080003
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Geschäftsführer
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    CHARLES, David Terrence
    21 The Drive
    Shelfield
    WS4 1PT Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    21 The Drive
    Shelfield
    WS4 1PT Walsall
    West Midlands
    EnglandBritish112556830002
    CHITTENDEN, Jeffrey George John
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    Geschäftsführer
    11 Sheldon Square
    W2 6DQ London
    Apartment 68
    United KingdomBritish123115670003
    DRURY, Thomas Waterworth
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Legh Cottage
    Legh Road
    WA16 8LS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish/Canadian29701240002
    FRITCHIE, Andrew Peel
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Orchard House
    Beckford Hall Beckford
    GL20 7AA Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish79149580001
    GALES, David Robert
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 The Pavillions End
    GU15 2LD Camberley
    Surrey
    British22498240002
    GITTINS, John Anthony
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    East Wing Leighton House
    Leighton Road Neston
    CH64 3SW Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish164311370001
    GRAHAM, Richard Halton
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    Geschäftsführer
    307 Sunup Holiday Park
    Ellicottville
    1473196 New York
    New York 14731-9604
    Usa
    Canadian120665310001
    HARDIE, Alistair John David
    Little Queens Beeches
    London Road
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Little Queens Beeches
    London Road
    SL5 7EQ Ascot
    Berkshire
    British58047230001
    HUNT, Andrew James
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Millswood
    Old Neighbouring, Chalford
    GL6 8AA Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish54503850003
    JONES, Martin Peter William
    The Mews Cottage Cranbourne Grange
    Hatchet Lane Cranbourne
    SL4 4RH Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Mews Cottage Cranbourne Grange
    Hatchet Lane Cranbourne
    SL4 4RH Ascot
    Berkshire
    British15332330002
    KLIM, Anthony Brian
    The Old Rectory
    Woolstone
    GL52 9RG Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Woolstone
    GL52 9RG Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish73852240002
    ORVES, James Riley
    5 Cumbrian Croft
    B63 1HG Halesowen
    West Midlands
    Geschäftsführer
    5 Cumbrian Croft
    B63 1HG Halesowen
    West Midlands
    British71362210001
    PARTINGTON, Andrew Charles
    Court Cottage
    Drift Road, Winkfield
    SL4 4RL Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Court Cottage
    Drift Road, Winkfield
    SL4 4RL Windsor
    Berkshire
    British70881120002
    SHEPHERD, Dale Stanley
    1004 Shenandoah Road
    IRISH Lexington
    Virginia 24450
    Usa
    Geschäftsführer
    1004 Shenandoah Road
    IRISH Lexington
    Virginia 24450
    Usa
    American124135650001
    SYMONDS, Christine Ann
    Ryde House, 5 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Ryde House, 5 The Woodlands
    Pedmore
    DY8 2RA Stourbridge
    West Midlands
    British24999120002
    THOMAS, Stephen Jeremy
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Willow Cottage
    Hill End Twyning
    GL20 6DW Tewkesbury
    Gloucestershire
    British97303290001
    WHITMORE, Gerald Michael
    Appletrees
    Church Street
    WR10 2JD Wyre Piddle
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Appletrees
    Church Street
    WR10 2JD Wyre Piddle
    Worcestershire
    United KingdomBritish41061870002
    WHITMORE, Jonathan Michael Thomas
    3a Avoncroft Road
    B60 4NG Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    3a Avoncroft Road
    B60 4NG Bromsgrove
    Worcestershire
    British87954770001

    Hat CRISP COMPUTING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. Mai 2002
    Geliefert am 09. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 24. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date in respect of the obligations of ingleby (1045) limited to the security agent under the terms of a loan note instrument constituting £10,477,500 9% secured loan notes together with interest and all other monies incurred by the security agent in relation to the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Apax Partners & Co. Ventures Limited(As Security Trustee and Agent for Itself and the Noteholders)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture to secure a guarantee
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 16. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date in respect of the obligations of ingleby (1045) limited to the security agent under the terms of the instrument constituting 9% £1,632,000 fixed rate c loan notes and all other sums due under this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Christine Ann Symonds,as Security Agent for Herself and the Noteholders (As Defined in Thedebenture)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture to secure a guarantee
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 16. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date in respect of the obligations of ingleby (1045) limited to the security agent under the terms of the instrument constituting 9% £1,632,000 fixed rate c loan notes and all other sums due under this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gerald Michael Whitmore,as Security Agent for Himself and the Noteholders (As Defined in Thedebenture)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge of intellectual property
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 10. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement or this charge
    Kurze Angaben
    All intellectual property rights throughout the world and/or registrations thereof all rights of copyright know how and other intellectual property rights of any description. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 10. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ingleby (1045) limited and crisp computing limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0