CRISP COMPUTING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CRISP COMPUTING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01547979 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CRISP COMPUTING LIMITED?
- (7222) /
Wo befindet sich CRISP COMPUTING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6th Floor 4 Grosvenor Place SW1X 7DL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CRISP COMPUTING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CRISP GROUP PLC | 18. Mai 1998 | 18. Mai 1998 |
| CRISP COMPUTING LIMITED | 09. Jan. 1985 | 09. Jan. 1985 |
| CROWNSTAR DEVELOPMENTS LIMITED | 02. März 1981 | 02. März 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CRISP COMPUTING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CRISP COMPUTING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Terence Sweeny am 17. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Pegasus House Kings Business Park Liverpool Road Prescot Merseyside L34 1PJ am 26. Aug. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeffrey Chittenden als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeffrey Chittenden als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CRISP COMPUTING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEFFIELD, Anne Louise | Sekretär | The Design Works 93 - 99 Goswell Road EC1V 7EY London Flat 15 | Other | 134678250001 | ||||||
| JAMES, Gavin Keith, Mr. | Geschäftsführer | Camelford Bradcutts Lane SL6 9AA Cookham Dean Berkshire | England | British | 44173560008 | |||||
| SWEENY, Paul Terence | Geschäftsführer | 98 Park Street W1K 6NZ London Flat 4 United Kingdom | United Kingdom | British | 140303320002 | |||||
| AMOS, David Stephen | Sekretär | 6 Acre Lane Webheath B97 5WN Redditch Worcestershire | British | 65186080003 | ||||||
| BIRKETT, Timothy Lloyd | Sekretär | 17 Padstow Drive Bramhall SK7 2HU Stockport Cheshire | British | 99698140001 | ||||||
| CROFT, Christopher Rendell | Sekretär | 2 Grimston Road SW6 3QP London | British | 55143000001 | ||||||
| FRITCHIE, Andrew Peel | Sekretär | Orchard House Beckford Hall Beckford GL20 7AA Tewkesbury Gloucestershire | British | 79149580001 | ||||||
| THOMAS, Stephen Jeremy | Sekretär | Willow Cottage Hill End Twyning GL20 6DW Tewkesbury Gloucestershire | British | 97303290001 | ||||||
| WHITMORE, Gerald Michael | Sekretär | 18 The Woodlands Pedmore DY8 2RA Stourbridge West Midlands | British | 41061870001 | ||||||
| UU SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Haweswater House, Lingley Mere Business Park Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3LP Warrington | 94063410003 | |||||||
| AMOS, David Stephen | Geschäftsführer | 6 Acre Lane Webheath B97 5WN Redditch Worcestershire | British | 65186080003 | ||||||
| BEVERIDGE, Robert James | Geschäftsführer | 81 Kidmore Road Caversham RG4 7NQ Reading | United Kingdom | British | 62452090001 | |||||
| CHARLES, David Terrence | Geschäftsführer | 21 The Drive Shelfield WS4 1PT Walsall West Midlands | England | British | 112556830002 | |||||
| CHITTENDEN, Jeffrey George John | Geschäftsführer | 11 Sheldon Square W2 6DQ London Apartment 68 | United Kingdom | British | 123115670003 | |||||
| DRURY, Thomas Waterworth | Geschäftsführer | Legh Cottage Legh Road WA16 8LS Knutsford Cheshire | United Kingdom | British/Canadian | 29701240002 | |||||
| FRITCHIE, Andrew Peel | Geschäftsführer | Orchard House Beckford Hall Beckford GL20 7AA Tewkesbury Gloucestershire | England | British | 79149580001 | |||||
| GALES, David Robert | Geschäftsführer | 4 The Pavillions End GU15 2LD Camberley Surrey | British | 22498240002 | ||||||
| GITTINS, John Anthony | Geschäftsführer | East Wing Leighton House Leighton Road Neston CH64 3SW Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 164311370001 | |||||
| GRAHAM, Richard Halton | Geschäftsführer | 307 Sunup Holiday Park Ellicottville 1473196 New York New York 14731-9604 Usa | Canadian | 120665310001 | ||||||
| HARDIE, Alistair John David | Geschäftsführer | Little Queens Beeches London Road SL5 7EQ Ascot Berkshire | British | 58047230001 | ||||||
| HUNT, Andrew James | Geschäftsführer | Millswood Old Neighbouring, Chalford GL6 8AA Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 54503850003 | |||||
| JONES, Martin Peter William | Geschäftsführer | The Mews Cottage Cranbourne Grange Hatchet Lane Cranbourne SL4 4RH Ascot Berkshire | British | 15332330002 | ||||||
| KLIM, Anthony Brian | Geschäftsführer | The Old Rectory Woolstone GL52 9RG Cheltenham Gloucestershire | England | British | 73852240002 | |||||
| ORVES, James Riley | Geschäftsführer | 5 Cumbrian Croft B63 1HG Halesowen West Midlands | British | 71362210001 | ||||||
| PARTINGTON, Andrew Charles | Geschäftsführer | Court Cottage Drift Road, Winkfield SL4 4RL Windsor Berkshire | British | 70881120002 | ||||||
| SHEPHERD, Dale Stanley | Geschäftsführer | 1004 Shenandoah Road IRISH Lexington Virginia 24450 Usa | American | 124135650001 | ||||||
| SYMONDS, Christine Ann | Geschäftsführer | Ryde House, 5 The Woodlands Pedmore DY8 2RA Stourbridge West Midlands | British | 24999120002 | ||||||
| THOMAS, Stephen Jeremy | Geschäftsführer | Willow Cottage Hill End Twyning GL20 6DW Tewkesbury Gloucestershire | British | 97303290001 | ||||||
| WHITMORE, Gerald Michael | Geschäftsführer | Appletrees Church Street WR10 2JD Wyre Piddle Worcestershire | United Kingdom | British | 41061870002 | |||||
| WHITMORE, Jonathan Michael Thomas | Geschäftsführer | 3a Avoncroft Road B60 4NG Bromsgrove Worcestershire | British | 87954770001 |
Hat CRISP COMPUTING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 07. Mai 2002 Geliefert am 09. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 24. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee of even date in respect of the obligations of ingleby (1045) limited to the security agent under the terms of a loan note instrument constituting £10,477,500 9% secured loan notes together with interest and all other monies incurred by the security agent in relation to the debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture to secure a guarantee | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 16. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date in respect of the obligations of ingleby (1045) limited to the security agent under the terms of the instrument constituting 9% £1,632,000 fixed rate c loan notes and all other sums due under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture to secure a guarantee | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 16. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date in respect of the obligations of ingleby (1045) limited to the security agent under the terms of the instrument constituting 9% £1,632,000 fixed rate c loan notes and all other sums due under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge of intellectual property | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 10. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement or this charge | |
Kurze Angaben All intellectual property rights throughout the world and/or registrations thereof all rights of copyright know how and other intellectual property rights of any description. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 10. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ingleby (1045) limited and crisp computing limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0