JESSAR ENGINEERING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | JESSAR ENGINEERING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01549991 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von JESSAR ENGINEERING LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich JESSAR ENGINEERING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Company Secretariat Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von JESSAR ENGINEERING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
JESSAR (1981) LIMITED | 11. März 1981 | 11. März 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JESSAR ENGINEERING LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für JESSAR ENGINEERING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Sept. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ashley Raymond Fulford am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Terry Wilkinson am 18. März 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Terry Wilkinson am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark David Sawyer am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Harold Gregory Barksdale am 18. März 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 |
Wer sind die Geschäftsführer von JESSAR ENGINEERING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILKINSON, Terry | Sekretär | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics United Kingdom | British | Controller Uk Fin | 80634780001 | |||||
BARKSDALE, Harold Gregory | Geschäftsführer | 1050 Westlakes Drive 19312 Berwyn Tyco Electronics Pennsylvania Usa | United States | American | Attorney | 137883380001 | ||||
FULFORD, Ashley Raymond | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics Devon United Kingdom | United Kingdom | British | Operations Manager | 125426610001 | ||||
SAWYER, Mark David | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics Wilts United Kingdom | England | British | Business Office Director | 123023180001 | ||||
WILKINSON, Terry | Geschäftsführer | Faraday Road Dorcan SN3 5HH Swindon Tyco Electronics United Kingdom | United Kingdom | British | Controller Uk Fin Serv | 80634780001 | ||||
ALLDRITT, Nigel Christopher | Sekretär | Beaumaris 215 Tamworth Road Kettlebrook B77 1BT Tamworth Staffordshire | British | Director | 4564310001 | |||||
GODDING, David Edward | Sekretär | Glebe Farmhouse Daglingworth GL7 7AE Cirencester Gloucestershire | British | 86621750001 | ||||||
GODFRAY, Terence William | Sekretär | 39 Robin Lane GU47 9AU Sandhurst Berkshire | British | 63510007 | ||||||
GREEN, Andrew Bernard | Sekretär | Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane Chapmanslade BA13 4AS Westbury Wiltshire | British | 62833460001 | ||||||
MIDDLETON, Trevor | Sekretär | 17 Northumberland Avenue Market Bosworth CV13 0RJ Nuneaton Warwickshire | British | Company Director | 43015670003 | |||||
ALLAN, Stuart | Geschäftsführer | 16 Fernham Gate SN7 7LR Faringdon Oxon | British | H R Manager | 78209550003 | |||||
ALLDRITT, Nigel Christopher | Geschäftsführer | Beaumaris 215 Tamworth Road Kettlebrook B77 1BT Tamworth Staffordshire | British | Director | 4564310001 | |||||
CLARKE, Graham James | Geschäftsführer | Winslow Coombe Ashbury SN6 8LN Swindon Wiltshire | British | Director | 45998730001 | |||||
COBLEY, Steven John | Geschäftsführer | 66 Rookery Road Knowle BS4 2DT Bristol | British | Controller Gic Emea | 80634650001 | |||||
COOKE, Timothy Hugh | Geschäftsführer | The Coppice Bowden Hill SN15 2PP Lacock Chippenham Wiltshire | British | Financial Director | 80681960001 | |||||
GATT, Tony Martin | Geschäftsführer | Hobbingfoot 48 High Street SG4 7LA Graveley Hertfordshire | United Kingdom | British | General Manager | 73889200001 | ||||
GILLESPIE, Alistair Neil | Geschäftsführer | 62 Swithland Lane Rothley LE7 7SE Leicester Leicestershire | British | Director | 5589350005 | |||||
GROVE, David Leslie | Geschäftsführer | Badgers Holt, Rookery Lane Lowsonford B95 5EP Solihull West Midlands | England | British | Company Director | 4174280001 | ||||
HERBERT, Michael David | Geschäftsführer | 22 Appleby Crescent Scotton HG5 9LS Knaresborough North Yorkshire | British | General Manager | 55542350001 | |||||
STUCKEY, Michael | Geschäftsführer | 34 Glen Brook Priorslee TF2 9QY Telford Shropshire | British | Director | 15174680002 | |||||
UMBERS, Paul Frederick | Geschäftsführer | 2 Beaminster Road B91 1NA Solihull West Midlands | England | British | Company Director | 39327850001 | ||||
WALL, Anthony Alfred | Geschäftsführer | 32 Hiplands Road B62 0AE Halesowen West Midlands | British | Commerical Director | 69623160001 |
Hat JESSAR ENGINEERING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Aug. 1998 Geliefert am 12. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 02. Juni 1998 Geliefert am 17. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Mai 1998 Geliefert am 09. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattels mortgage | Erstellt am 17. Juni 1993 Geliefert am 17. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 new bliss model C400 press tog with special bottom ejection mechanism and linear type feed unit serial no B916-19273-1991. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Jan. 1991 Geliefert am 06. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 29. Jan. 1991 Geliefert am 05. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the factoring agreement dated 29TH january 1991. | |
Kurze Angaben First by way of fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company as far as any invoice (as defined in the factoring agreement) does not vest or has not vested in the factor and secondly - by way of floating charge all the property rights and assets of the company charged by way of specific charge pursuant to clause 2-1-1 in the debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 21. Jan. 1983 Geliefert am 31. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book & other debts now & from time to time due. Fronting charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0