KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED

KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01552539
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pinnacle 5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    23 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Feb. 2017

    11 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Aug. 2016

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. März 2016

    10 Seiten2.24B

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Ronald Anthony Maycock als Geschäftsführer am 14. Jan. 2016

    2 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    13 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kiveton Park Sheffield South Yorkshire S26 6NQ zum Pinnacle 5th Floor 67 Albion Street Leeds LS1 5AA am 08. Okt. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Anthony Maycock als Geschäftsführer am 31. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    31 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 129,311
    SH01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    33 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 129,311
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Verschiedenes

    Section 519 of the companies act 2006
    1 SeitenMISC

    Ernennung von Mr Nigel Ashley Blatherwick als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Ronald Anthony Maycock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012

    33 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Kathleen Bates-Williams als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    33 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HARRIS, Philip Jeffrey
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    Sekretär
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    British102431660001
    BLATHERWICK, Geoffrey
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    Geschäftsführer
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    United KingdomBritish3775240001
    BLATHERWICK, Nigel Ashley
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    Geschäftsführer
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    EnglandBritish179482180001
    HARRIS, Philip Jeffrey
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    Geschäftsführer
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    EnglandBritish102431660001
    BATES-WILLIAMS, Kathleen
    3 Walnut Tree Cottage
    Brookhouse Nr Laughton
    S25 1YA Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    3 Walnut Tree Cottage
    Brookhouse Nr Laughton
    S25 1YA Sheffield
    South Yorkshire
    British3767990001
    PATTISON, Eric
    9 Rackford Road
    Anston
    S25 4DE Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    9 Rackford Road
    Anston
    S25 4DE Sheffield
    South Yorkshire
    British24710210001
    WINTERBOTTOM, Roger
    4 Linden Crescent
    Stocksbridge
    S30 5DF Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    4 Linden Crescent
    Stocksbridge
    S30 5DF Sheffield
    South Yorkshire
    British4441710001
    BATES-WILLIAMS, Kathleen
    Kiveton Park
    S26 6NQ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiveton Park
    S26 6NQ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish3767990001
    HAMMOND, Brian
    Old Well Cottage
    Kidmore End
    RG4 9AX Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Old Well Cottage
    Kidmore End
    RG4 9AX Reading
    Berkshire
    British3767980001
    JOWETT, John Gordon
    Sparrows North Street
    Westbourne
    PO10 8SP Emsworth
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Sparrows North Street
    Westbourne
    PO10 8SP Emsworth
    Hampshire
    British21606430001
    LING, Michael John
    15 0sborne Road
    Todwick
    S26 1HX Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 0sborne Road
    Todwick
    S26 1HX Sheffield
    South Yorkshire
    British19297240001
    MAYCOCK, Anthony
    Kiveton Park
    S26 6NQ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiveton Park
    S26 6NQ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish3775260001
    MAYCOCK, Ronald Anthony
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    Geschäftsführer
    5th Floor
    67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle
    EnglandBritish121490260001

    Hat KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Feb. 2011
    Geliefert am 16. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juli 1986
    Geliefert am 29. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the the company and/or kiveton park steel & wire works limited and greaves of sheffield limited and barmond international limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    L/H property situate at the corner of sidney street and matilda street, sheffield in the county of south yorkshire title nos:- ywe 60662, syk 134129 syk 134130, syk 152438 including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Limited Company
    Transaktionen
    • 29. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    • 25. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Feb. 1986
    Geliefert am 13. März 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or kiveton park steel and wire works limited, greaves of sheffield limited, and barmond international limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 13. März 1986Registrierung einer Belastung
    • 17. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 1984
    Geliefert am 24. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - 28 sidney street, sheffield, or in the proceeds of sale thereof. T.n - syk 152438.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 1984
    Geliefert am 24. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - 28 sidney street sheffield. Or in the proceeds of sale thereof. T.n- syk 134129.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 1984
    Geliefert am 24. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - land on the north west side of sidney street, sheffield or in the proceeds of sale thereof. T.n- ywe 60662.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 1984
    Geliefert am 24. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H - exchange works, sidney street, sheffield or in the proceeds of sale thereof. T.n - syk 134130.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 26. Apr. 1984
    Geliefert am 02. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all book and other debts owed the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. (Excluding those mentioned above).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 1982
    Geliefert am 13. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the bank from greaves of sheffield limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    L/H 28 sidney st sheffield and the proceeds of sale thereof title no syk 152438.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 21. Sept. 1982
    Geliefert am 24. Sept. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the bank from greaves of sheffield limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Exchange works sidney st sheffield title no syk 134130.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 21. Sept. 1982
    Geliefert am 24. Sept. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the bank from greaves of sheffield limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    28 sidney st sheffield title no syk 134129.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Sept. 1982
    Geliefert am 24. Sept. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the bank from greaves of sheffield limited on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the north west side of sidney st sheffield title no ywe 60662.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat KIVETON PARK (HOLDINGS) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Sept. 2015Beginn der Verwaltung
    16. Sept. 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Philip Edward Pierce
    Pinnacle 5th Floor, 67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Pinnacle 5th Floor, 67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    West Yorkshire
    Ben Woolrych
    Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0