FURLONG HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFURLONG HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01558415
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FURLONG HOMES LIMITED?

    • Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen

    Wo befindet sich FURLONG HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FURLONG HOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FURLONG BROTHERS (CONSTRUCTION) LIMITED31. Dez. 198131. Dez. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FURLONG HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FURLONG HOMES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für FURLONG HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 2
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016

    1 SeitenAA01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 04. Feb. 2015

    17 SeitenRP04

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 04. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 394,239
    SH01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    19. Feb. 2015Clarification A second filed AR01 was registered on 19/02/2015

    Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 218 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 173 vollständig

    4 SeitenMR04

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 394,239
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Catchpole als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Jon William Mortimore als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von FURLONG HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808430001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    BROWN, Carole Elizabeth
    The Old Bakehouse
    School Lane Loughton
    MK5 8AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    The Old Bakehouse
    School Lane Loughton
    MK5 8AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British98235420001
    FOWLER, Mark Townshend
    25 Louvain Drive
    CM1 6BA Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    25 Louvain Drive
    CM1 6BA Chelmsford
    Essex
    British86376790001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Sekretär
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    GOREHAM, Lee
    6 Aston Road
    SG11 1PX Standon
    Hertfordshire
    Sekretär
    6 Aston Road
    SG11 1PX Standon
    Hertfordshire
    British91122540001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    LOBATTO, Paul Jeremy
    4 Barley Brow
    WD25 0JW Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    4 Barley Brow
    WD25 0JW Watford
    Hertfordshire
    British78687810002
    WISEMAN, Andrew Graham
    37 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AE London
    Sekretär
    37 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AE London
    British900300001
    WISEMAN, David William
    1 Goodwood Close
    Clophill
    MK45 4FE Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    1 Goodwood Close
    Clophill
    MK45 4FE Bedford
    Bedfordshire
    British92390300001
    BAUCKHAM, Grant
    Upton House
    Southey Green
    CO9 3RN Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    Upton House
    Southey Green
    CO9 3RN Halstead
    Essex
    British105774130001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Geschäftsführer
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    Geschäftsführer
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    EnglandBritish98235420004
    BROWN, Carole Elizabeth
    The Old Bakehouse
    School Lane Loughton
    MK5 8AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Bakehouse
    School Lane Loughton
    MK5 8AT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish98235420001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COLLINS, Gillian Anne
    2 Silistria Drive
    GU21 2TL Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Silistria Drive
    GU21 2TL Woking
    Surrey
    British86441230001
    CURLE, Mark John
    Brightside
    CM12 0LH Billericay
    51
    Essex
    Geschäftsführer
    Brightside
    CM12 0LH Billericay
    51
    Essex
    EnglandBritish132313480001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DURANT, David Leonard
    34 Holly Crescent
    IG8 9PD Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    34 Holly Crescent
    IG8 9PD Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish50912280001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FURLONG, David George
    8 Butterworth Gardens
    IG8 0BJ Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Butterworth Gardens
    IG8 0BJ Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish5464370002
    FURLONG, James Henry
    Athelstane
    103 Coppice Row Theydon Bois
    CM16 7DW
    Essex
    Geschäftsführer
    Athelstane
    103 Coppice Row Theydon Bois
    CM16 7DW
    Essex
    United KingdomBritish5464360001
    FURLONG, Kenneth Paul
    13 St Theresa Court
    E4 7UD London
    Geschäftsführer
    13 St Theresa Court
    E4 7UD London
    British5464380001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GARNER, Tony Christopher
    7 Grange Road
    MK45 4RE Barton Le Clay
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    7 Grange Road
    MK45 4RE Barton Le Clay
    Bedfordshire
    EnglandBritish79630360001
    JAMES, Peter
    9 High View Road
    South Woodford
    E18 2HN London
    Geschäftsführer
    9 High View Road
    South Woodford
    E18 2HN London
    EnglandBritish86901660001
    JONES, Steve Keith
    3 Frances Green
    Beaulieu Park
    CM1 6EG Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    3 Frances Green
    Beaulieu Park
    CM1 6EG Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish171220150001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEGGETT, Martin
    6 Longman Close Blackmoor Lane
    Croxley Green
    WD18 8WP Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Longman Close Blackmoor Lane
    Croxley Green
    WD18 8WP Watford
    Hertfordshire
    British98041520001
    LOBATTO, Paul Jeremy
    4 Barley Brow
    WD25 0JW Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    4 Barley Brow
    WD25 0JW Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish78687810002
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    MURPHY, John William
    19 Esplanade Gardens
    SS0 8JP Westcliff On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    19 Esplanade Gardens
    SS0 8JP Westcliff On Sea
    Essex
    EnglandBritish202959810002

    Hat FURLONG HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 20. Jan. 2009
    Geliefert am 23. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £85,250.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a regents court slexandra road southend-on-sea t/no EX192706 being subject to and with the benefit of the lease of 22 flats.
    Berechtigte Personen
    • Freehold Managers (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge
    Erstellt am 09. Jan. 2009
    Geliefert am 15. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £732,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Anchor street bishops stortford t/no HD393406 and HD393408.
    Berechtigte Personen
    • Freehold Managers (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge
    Erstellt am 09. Jan. 2009
    Geliefert am 15. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £107,250.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Riverhead close walthamstow t/no EGL470924.
    Berechtigte Personen
    • Freehold Managers (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Sept. 2005
    Geliefert am 15. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 375 cockfosters road, hadley wood t/no. EGL236902. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 2005
    Geliefert am 02. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 56 buckingham street (even) aylesbury aylesbury vale buckinghamshire t/n BM137360. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 14. März 2005
    Geliefert am 31. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a hammarsfield standon near ware. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juni 2004
    Geliefert am 30. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property k/a 151 alexandra road southend-on-sea t/n EX192706. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2004
    Geliefert am 30. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h /l/h property k/a abbey road, barking, t/no EGL70896, P42271, EGL47290, NGL22151, NGL177264, EGL426360 and part of t/no EGL106917 as well as nregistered land pf P42271. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 17. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at riverhead close walthamstow waltham forest london t/no EGL185355. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2004
    Geliefert am 11. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property known as former priory meadow school rockford road st osyth clacton t/n EX692773 and EX715551. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Aug. 2003
    Geliefert am 14. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land at anchor street bishops stortford hertfordshire t/nos: HD393408 and HD393406. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Feb. 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property known as 331 romford road forest gate newham E7 8AA t/n EGL400959. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a kingsbridge arms public house west ferry road poplar t/n 221905. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The former gas holder site brook street tring t/no: HD393154. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. März 2002
    Geliefert am 19. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 61 albert square west ham london E15 1HJ t/no: EGL50487. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 2002
    Geliefert am 19. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land on the north-east side of fisherton street and the f/h property k/a the phoenix public house 43 and 44 frampton street london NW8 t/nos: NGL799763 249867. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 2002
    Geliefert am 19. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at susannah street and 189-195 (odd numbers) east india dock road poplar london E14 t/no: EGL423191. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Aug. 2001
    Geliefert am 06. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the land on the east side of linden way southgate t/no: MX404600.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juli 2001
    Geliefert am 12. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at 46A, 47, 47A, 49 and 50 brooksby's walk hackney london E9 6DAT/no: NGL198572. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Mai 2001
    Geliefert am 30. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h land and premises k/a 1/23 linden way old southgate, london N14 4LT t/ns MX296655 and MX131622.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 2001
    Geliefert am 08. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 29-37 clapton square t/nos 335515,335514,335516,335510,335511,87938,LN33898,335512,335513 and 335517. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 2001
    Geliefert am 08. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 16 uphill drive mill hill t/no MX207170. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Feb. 2001
    Geliefert am 21. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 28 and 30 high street wanstead east london t/no: NGL28397. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Dez. 2000
    Geliefert am 20. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H east side of york road waltham cross t/no;-HD384270. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0