ELISABETH THE CHEF LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ELISABETH THE CHEF LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01561100 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ELISABETH THE CHEF LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. (10890) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 50 Pontefract Lane LS9 8HY Leeds England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SENOBLE UK LIMITED | 01. Juli 2011 | 01. Juli 2011 |
| ELISABETH THE CHEF LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| CAPECLASS LIMITED | 13. Mai 1981 | 13. Mai 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Apr. 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Jan. 2027 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 23. Apr. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 07. Mai 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 23. Apr. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2025 | 16 Seiten | AA | ||
Change of details for Elisabeth the Chef Holdings Limited as a person with significant control on 30. Okt. 2025 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2024 | 17 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2023 | 22 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2022 | 22 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Joseph Anthony Wood als Geschäftsführer am 28. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2021 | 23 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 21 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2019 | 24 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate Leamington Spa Warwickshire CV31 1NB zum 50 Pontefract Lane Leeds LS9 8HY am 12. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2018 bis 30. Apr. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 27 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 29 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Notification of Elisabeth the Chef Holdings Limited as a person with significant control on 01. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||
Cessation of Marc Claude Andre Senoble as a person with significant control on 01. Nov. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||
Ernennung von Mr Charles Joseph Wood als Direktor am 01. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Joseph Anthony Wood als Direktor am 01. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD, Charles Joseph | Geschäftsführer | Pontefract Lane LS9 8HY Leeds 50 England | England | British | 73248470002 | |||||
| CHALMERS, Julie Anne | Sekretär | 6 The Hamlet Leek Wootton CV35 7QW Warwick Warwickshire | British | 27576500002 | ||||||
| MOORHOUSE, Robert Thomas | Sekretär | 1 Glebeland Close Thrussington LE7 4TT Leicester Leicestershire | British | 61955460001 | ||||||
| AVRAIN, Guillaume Jean Joel Daniel | Geschäftsführer | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Senoble Uk Warwickshire United Kingdom | England | French | 288149810001 | |||||
| BALMER, Stephen David | Geschäftsführer | 8 Charnwood Way Lillington CV32 7BU Leamington Spa Warwickshire | British | 44592470001 | ||||||
| BECARD, Arnaud, Mister | Geschäftsführer | 30 Rue Des Jacquins 89100 Jouy Senso Yonne France | France | French | 207057420001 | |||||
| BESSET, Olivier Francois Yves | Geschäftsführer | Rue Des Jacquins C/O Senoble Holding, 30 Rue Des Jacquins 89150 Jouy C/O Senoble Holding 30 France | France | French | 176990840001 | |||||
| BRILEY, Colin John | Geschäftsführer | 410 Quinton Road West Quinton B32 1QG Birmingham | British | 44744190001 | ||||||
| CHALMERS, Julie Anne | Geschäftsführer | 6 The Hamlet Leek Wootton CV35 7QW Warwick Warwickshire | British | 27576500002 | ||||||
| DANIELL, Christopher | Geschäftsführer | Ashley Farm Staunton-On-Arrow HR6 9LN Leominster Herefordshire | British | 27576490001 | ||||||
| DAVE, Lewis, Mister | Geschäftsführer | 4 Berrington Road Syndenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Senoble Uk Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | English | 207113220001 | |||||
| EASTHAM, Stephen Ralph | Geschäftsführer | 9 Pitters Piece Long Crendon HP18 9PP Aylesbury Buckinghamshire | British | 78805340001 | ||||||
| GIBSON, John Frederick | Geschäftsführer | Orchard Farmhouse Cowfold Lane Rotherwick RG27 9BP Hook Hampshire | British | 63211360001 | ||||||
| HARRIS, Anthony Beauchamp | Geschäftsführer | 1 Norland Road Clifton BS8 3LP Bristol Avon | United Kingdom | British | 10913260001 | |||||
| HAYWOOD, William Sothern | Geschäftsführer | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | 134536420001 | |||||
| INTERNATIONAL, Senoble | Geschäftsführer | Place Du Champ De Mars Brussels 1050 5 Belgium | Belgium | English | 176921600001 | |||||
| JOHNSON, Andrew Bainbridge | Geschäftsführer | The Old Rectory 15 High Street LE15 9DN Morcott Leicestershire | United Kingdom | British | 97381620001 | |||||
| MARSHALL, Christopher Miller | Geschäftsführer | Field House 3 Dovecote Drive Welton LN2 3UA Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 61955820001 | |||||
| MOORHOUSE, Robert Thomas | Geschäftsführer | 1 Glebeland Close Thrussington LE7 4TT Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 61955460001 | |||||
| OWEN, David Jeremy, Mbe | Geschäftsführer | The Old Rectory Birdingbury CV23 8EW Rugby Warwickshire | England | British | 27576480001 | |||||
| OWEN, Ena Emily | Geschäftsführer | Harrow Lodge West Avenue Stoke Park Coventry West Midlands | British | 27576520001 | ||||||
| OWEN, Hilary Patricia | Geschäftsführer | The Old Rectory Birdingbury CV23 8EW Rugby Warwickshire | British | 27576510001 | ||||||
| OWEN, Julian Christopher | Geschäftsführer | The Old Mill Tredington CV36 4NJ Shipston On Stour Warwickshire | England | British | 73549290001 | |||||
| PECK, Andy | Geschäftsführer | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | England | British | 184282610001 | |||||
| PIERRARD, Jean-Christophe | Geschäftsführer | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | French | 158294970001 | |||||
| PORTERGILL, Richard George | Geschäftsführer | Upway Highmoor Cross RG9 5DT Henley On Thames Oxfordshire | British | 2563880001 | ||||||
| SALAMON, Francois | Geschäftsführer | c/o C/O Senoble Holding Rue Des Jacquins 89150 Jouy 30 France | France | French | 136452470001 | |||||
| SENOBLE, Marc | Geschäftsführer | c/o C/O Senoble Holding Rue Des Jacquins 89150 Jouy 30 France | France | French | 124986450001 | |||||
| TISSEAU, Pascal Louis Alphonse Joseph | Geschäftsführer | c/o C/O Senoble Holding Rue Des Jacquins 89150 Jouy 30 France | France | French | 136452410002 | |||||
| VALDHER, Eric | Geschäftsführer | 4 Berrington Road Sydenham Industrial Estate CV31 1NB Leamington Spa Warwickshire | England | French | 149457870001 | |||||
| WOOD, Joseph Anthony | Geschäftsführer | Pontefract Lane LS9 8HY Leeds 50 England | England | British | 218325180001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ELISABETH THE CHEF LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth The Chef Holdings Limited | 01. Nov. 2017 | Pontefract Lane LS9 8HY Leeds 50 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Marc Claude Andre Senoble | 06. Apr. 2016 | Rue Du Pepin Brussels 31/37 Belgium | Ja | ||||||||||
Nationalität: French Staatsangehörigkeit: Belgium | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0