SPARTAN SHEFFIELD LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SPARTAN SHEFFIELD LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01563444 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SPARTAN SHEFFIELD LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich SPARTAN SHEFFIELD LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Firth House PO BOX 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SPARTAN SHEFFIELD LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| B & N (NO.33) LIMITED | 21. Mai 1981 | 21. Mai 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPARTAN SHEFFIELD LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SPARTAN SHEFFIELD LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Hart als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher David Seymour als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Thomas Hart am 16. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Peter Simon Bland am 16. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Christine Jane Alison Dalton am 16. Mai 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SPARTAN SHEFFIELD LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALTON, Christine Jane Alison | Sekretär | Firth House PO BOX 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire | British | 29941080001 | ||||||
| BLAND, Peter Simon | Geschäftsführer | Firth House PO BOX 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 42351130005 | |||||
| SEYMOUR, Christopher David | Geschäftsführer | Firth House PO BOX 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire | England | British | 158310680001 | |||||
| ATKINSON, Mandy Elizabeth | Sekretär | The Old School House Hopton Hall Lane WF14 8HP Mirfield West Yorkshire | British | 56543190002 | ||||||
| BERGIN, John Charles Michael Francis | Sekretär | 24 Northgate Tickhill DN11 9HY Doncaster South Yorkshire | British | 12452990001 | ||||||
| FLAHERTY, Patrick | Sekretär | 38 Tannery Street S13 7JW Sheffield South Yorkshire | British | 13282030001 | ||||||
| AINSWORTH, Sydney | Geschäftsführer | Highway Derwent Lane Hathersage Hope Valley S32 1AS Sheffield Derbyshire | British | 56543130001 | ||||||
| BERGIN, John Charles Michael Francis | Geschäftsführer | 24 Northgate Tickhill DN11 9HY Doncaster South Yorkshire | England | British | 12452990001 | |||||
| CARR, Michael Lewis | Geschäftsführer | Flat 7 46 Elm Park Road SW3 6AX London | British | 36816040001 | ||||||
| FLAHERTY, Patrick | Geschäftsführer | 38 Tannery Street S13 7JW Sheffield South Yorkshire | British | 13282030001 | ||||||
| HALL, David John | Geschäftsführer | Craglands Ashopton Road, Bamford S33 0DB Hope Valley Derbyshire | British | 40070600001 | ||||||
| HART, James Thomas | Geschäftsführer | Firth House PO BOX 644 Meadowhall Road S9 1JD Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 115557140002 | |||||
| JONES, Trevor Alexander | Geschäftsführer | 67b Blomfield Road W9 2PA London | British | 61273750001 | ||||||
| MACDONALD, Neil Andrew | Geschäftsführer | 21 Clarendon Road S10 3TQ Sheffield South Yorkshire | England | British | 3696630003 | |||||
| MOODY, David Barker | Geschäftsführer | Ivas Wood Round Green Lane Stainborough S75 3EL Barnsley S Yorks | England | British | 21118810001 | |||||
| STREET, Anthony James | Geschäftsführer | 47 Durlstone Grove S12 2TU Sheffield South Yorkshire | British | 13282040001 |
Hat SPARTAN SHEFFIELD LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Chattel mortgage | Erstellt am 15. Nov. 1995 Geliefert am 17. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Run out table and bar lift and transfer for collecting bars finished in stand 2 and transporting them to the line off shearing table,stand 4 run-out table with lift-off fingers a bar saver device and an off line cutting table and various other chattels see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 08. Dez. 1994 Geliefert am 16. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 72399022. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge over book debts | Erstellt am 05. Apr. 1993 Geliefert am 06. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under a factoring agreement,leasing agreement or otherwise. | |
Kurze Angaben First the ultimate balance due or owing to the company by tih under any present or future factoring agreement providing for the purchase by tih of bookdebts of the company and without limitation to the foregoing the ultimate balance due or owing to the company by tih under a factoring agreement dated 25 march 1993. secondly all other book and other debts and claims both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 16. Okt. 1992 Geliefert am 26. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the "deposit(s)" (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1990 Geliefert am 04. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £500,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben Land to the west of stainforth road and to the south of attercliffe road sheffield t/n syk 138786 syk 138787 syk 138788 syk 138789 and syk 222441 land on the west side of stainforth road sheffield t/n syk 138785. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 24. Sept. 1981 Geliefert am 13. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All those pieces of land and buildings now known as attercliffe works attercliffe road sheffield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Sept. 1981 Geliefert am 22. Sept. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SPARTAN SHEFFIELD LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0