COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01564807 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Brook Road Wimborne BH21 2BJ Dorset |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WALLOP HOLDINGS LIMITED | 29. Mai 1981 | 29. Mai 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Jan. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth John Morrison als Direktor am 01. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Skinner als Geschäftsführer am 01. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Lyn Carol Colloff am 01. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalit ät | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLOFF, Lyn Carol | Sekretär | Brook Road Wimborne BH21 2BJ Dorset | British | Chartered Secretary | 3771140003 | |||||
COLLOFF, Lyn Carol | Geschäftsführer | Brook Road Wimborne BH21 2BJ Dorset | England | British | Chartered Secretary | 3771140004 | ||||
MORRISON, Kenneth John | Geschäftsführer | Brook Road Wimborne BH21 2BJ Dorset | England | British | Director | 100751190001 | ||||
BANNING, Paul | Sekretär | 11 Tavy Close SO53 4SN Eastleigh Hampshire | British | Accountant | 98858930001 | |||||
FRENCH, Wayne Ian | Sekretär | 3 Oakfields Allbrook SO50 4RP Eastleigh Hampshire | British | Finance Director | 104188800001 | |||||
LOVERIDGE, James Douglas | Sekretär | 10 Redding Drive HP6 5PX Amersham Buckinghamshire | British | 2641580001 | ||||||
NIGHTINGALE, John Paul Martin | Sekretär | Billington Gardens Hedge End SO30 2RT Southampton 94 Hampshire | British | Accountant | 102032030001 | |||||
SISMEY, Richard George | Sekretär | 3 Caradon Place BH31 7PW Verwood Dorset | British | Finance Director | 109692340001 | |||||
BANNING, Paul | Geschäftsführer | 11 Tavy Close SO53 4SN Eastleigh Hampshire | England | British | Accountant | 98858930001 | ||||
BRYSON, John Macdonald | Geschäftsführer | Edgton Little Tangley Wonersh GU5 0PW Guildford Surrey | British | Finance Director | 10076550001 | |||||
CLARK, Robin Hartley Ledgerd | Geschäftsführer | Glebe Cottage Rockbourne SP6 3NA Fordingbridge Hampshire | British | Managing Director | 73934900001 | |||||
FRENCH, Wayne Ian | Geschäftsführer | 3 Oakfields Allbrook SO50 4RP Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 104188800001 | ||||
LONG, Paul David | Geschäftsführer | Brook Road Wimborne BH21 2BJ Dorset | United Kingdom | British | Accountant/Director | 102955000012 | ||||
LOVERIDGE, James Douglas | Geschäftsführer | 10 Redding Drive HP6 5PX Amersham Buckinghamshire | England | British | Solicitor | 2641580001 | ||||
NIGHTINGALE, John Paul Martin | Geschäftsführer | Billington Gardens Hedge End SO30 2RT Southampton 94 Hampshire | England | British | Accountant | 102032030001 | ||||
PICKERING, Ian | Geschäftsführer | 5 Sandbrier Close Walnut Tree MK7 7DU Milton Keynes Buckinghamshire | British | Group Financial Controller | 3014270001 | |||||
SISMEY, Richard George | Geschäftsführer | 3 Caradon Place BH31 7PW Verwood Dorset | United Kingdom | British | Finance Director | 109692340001 | ||||
SKINNER, Stephen John | Geschäftsführer | Brook Road Wimborne BH21 2BJ Dorset | England | British | Director | 178014500001 | ||||
STEVENS, Andrew John | Geschäftsführer | Cobham Plc Brook Road BH21 2BJ Wimborne Dorset | England | British | Managing Director | 244773720001 | ||||
VINCENT, Michelle Jane | Geschäftsführer | The Old Dairy Farm Hazelbury Bryan DT10 2ES Sturminster Newton 13 Dorset | England | British | Finance Director | 120134680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight Refuelling Limited | 06. Apr. 2016 | Brook Road BH21 2BJ Wimborne C/O Cobham Plc England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat COBHAM COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Aug. 1992 Geliefert am 17. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 08. Okt. 1985 Geliefert am 18. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 25. Okt. 1984 Geliefert am 01. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 16. Okt. 1984 Geliefert am 25. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 21. Nov. 1983 Geliefert am 28. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 29. Sept. 1982 Geliefert am 07. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1982 Geliefert am 10. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H part of ex chapel river press site, weyhill road, andover hampshire as comprised in a conveyance dated 30.7.82 and a deed of mutual grant dated 30.7.82. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 26. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 19. Mai 1982 Geliefert am 09. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0