SAWP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SAWP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01565544 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SAWP LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SAWP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SAWP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SOUTHERN AND WESTERN PRESS LIMITED | 15. Nov. 1984 | 15. Nov. 1984 |
SURREY PROPERTY MAIL LIMITED | 02. Juni 1981 | 02. Juni 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SAWP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 25. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SAWP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. März 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Hunter am 26. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Hunter am 13. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Neil Edward Carpenter am 13. Jan. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Simon Alton Westrop am 13. Jan. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Henry Kennedy Faure Walker am 13. Jan. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP zum Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY am 11. Dez. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Davidson als Geschäftsführer am 11. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Henry Kennedy Faure Walker als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SAWP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Sekretär | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Sekretär | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Geschäftsführer | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Geschäftsführer | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Finance Director | 69320190004 | ||||
BLACKNELL, David | Sekretär | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | 7332320001 | ||||||
BRESNARK, Lawrence | Sekretär | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
GLASS, Josephine Mary | Sekretär | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | 44504060001 | ||||||
HUNTER, Paul Anthony | Sekretär | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
TOWNSEND, John Arthur | Sekretär | 36 Guithavon Road CM8 1HD Witham Essex | British | 7332310001 | ||||||
AIKEN, Iain William | Geschäftsführer | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
BLACKNELL, David | Geschäftsführer | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | Company Secretary | 7332320001 | |||||
BRESNARK, Lawrence | Geschäftsführer | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
BROWN, James Thomson | Geschäftsführer | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Exec | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Geschäftsführer | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Newspaper Publisher | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Geschäftsführer | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
GRAHAM, John Stuart | Geschäftsführer | 10 Hatley Close Friern Barnet N11 3LN London | British | Chartered Accountant | 72224100001 | |||||
HARRIS, Philip James | Geschäftsführer | 18 Palairet Close BA15 1US Bradford On Avon Wiltshire | British | Newspaper Director | 26617980001 | |||||
MATTHEWS, David John | Geschäftsführer | 17 Orwell Drive Keynsham BS18 1QB Bristol Avon | British | Accountant | 26617990001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Geschäftsführer | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
RADBURN, Philip Arthur | Geschäftsführer | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
SKINNER, Peter John | Geschäftsführer | 22 Beresford Gardens SS7 2SA Hadleigh Essex | British | Chartered Accountant | 7332340001 | |||||
STEVENSON, Hew Shannan | Geschäftsführer | 42 Canonbury Square N1 2AW London | British | Newspaper Director | 8030630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SAWP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media Group Limited | 06. Apr. 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SAWP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Erstellt am 01. Juni 1989 Geliefert am 10. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land & buildings situated as southover wells somerset together with all buildings & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 01. Juni 1989 Geliefert am 10. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 14. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a southover wells, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Jan. 1989 Geliefert am 03. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £420,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H land & buildings situate at southover at wells in the county of somerset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 02. März 1987 Geliefert am 06. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a southern wills, somerset and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 29. Jan. 1987 Geliefert am 06. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Dez. 1986 Geliefert am 20. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over bookdebts | Erstellt am 14. März 1985 Geliefert am 22. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be owing the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 27. Aug. 1982 Geliefert am 03. Sept. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts, floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0