RADIO WYVERN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRADIO WYVERN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01568552
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RADIO WYVERN LIMITED?

    • Produktion von Fernsehprogrammen (59113) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich RADIO WYVERN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RADIO WYVERN LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RADIO WYVERN PUBLIC LIMITED COMPANY31. Dez. 198131. Dez. 1981
    LEXDEN PUBLIC LIMITED COMPANY16. Juni 198116. Juni 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RADIO WYVERN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für RADIO WYVERN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    13 SeitenAA

    legacy

    38 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2018

    • Kapital: GBP 1,000.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Keenan am 26. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Deidre Ann Ford am 26. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von RADIO WYVERN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Sekretär
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish119137220004
    BELLEW, Joanne Louise
    52 Tydeman Road
    BS20 7LS Portishead
    North Somerset
    Sekretär
    52 Tydeman Road
    BS20 7LS Portishead
    North Somerset
    British66765990003
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    British54693600002
    GIFFARD-TAYLOR, Barrie
    41 New Road
    SN15 1JQ Chippenham
    Wiltshire
    Sekretär
    41 New Road
    SN15 1JQ Chippenham
    Wiltshire
    British9984510001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Sekretär
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    British77961690001
    OWENS, John Michael
    19 Eastbank Drive
    Northwick
    WR3 7BH Worcester
    Worcestershire
    Sekretär
    19 Eastbank Drive
    Northwick
    WR3 7BH Worcester
    Worcestershire
    British27014120001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    ALLEN, Charles Lamb
    Victoria Road
    W8 5RH London
    71
    Geschäftsführer
    Victoria Road
    W8 5RH London
    71
    United KingdomBritish142635780001
    BERNARD, Ralph Mitchell
    Hydecross
    Cross Lane
    SN8 1JZ Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Hydecross
    Cross Lane
    SN8 1JZ Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish32493590003
    BILTON, Norman Bruce
    65 Tennyson Drive
    St James Park
    WR14 2UL Malvern
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    65 Tennyson Drive
    St James Park
    WR14 2UL Malvern
    Worcestershire
    British35796760001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Geschäftsführer
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrish47934750001
    CORBETT, Robert Anthony
    Newchurch Farm
    Kinnersley
    HR3 6QQ Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Newchurch Farm
    Kinnersley
    HR3 6QQ Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish24189480001
    COTTERELL BARONET, John Henry Geers, Sir
    Estate Office Garnons
    Byford
    HR4 7JX Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Estate Office Garnons
    Byford
    HR4 7JX Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish52656750002
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish54693600002
    HILL, Peter Saxty
    22 King Street
    HR4 9DA Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    22 King Street
    HR4 9DA Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish76724330001
    MANNING, Richard Denley John
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    Geschäftsführer
    39 Ash Lane
    BA5 2LR Wells
    Somerset
    United KingdomBritish77961690001
    MARSH, Peter
    14 Manor Road
    Hanbury Park St Johns
    WR2 4PD Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    14 Manor Road
    Hanbury Park St Johns
    WR2 4PD Worcester
    Worcestershire
    British6241810002
    MEARS, Evelyn
    Ratefield Farm
    Kimbolton
    HR6 0JB Leominster
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    Ratefield Farm
    Kimbolton
    HR6 0JB Leominster
    Herefordshire
    British27014150001
    PALLOT, Wendy Monica
    The Willows
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    The Willows
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish74832570006
    RILEY, Philip Stephen
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish140085310001
    RUFUS, Ian Douglas
    55 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    55 Whitemoor Drive
    Monkspath
    B90 4UL Solihull
    West Midlands
    British14867850005
    TABOR, Ashley Daniel
    Appt 11-02 The Knightsbridge
    Apartments 199 Knightsbridge
    SW7 1RH London
    Geschäftsführer
    Appt 11-02 The Knightsbridge
    Apartments 199 Knightsbridge
    SW7 1RH London
    United KingdomBritish56313240002
    TAYLOR, John Patrick Enfield
    Pitt House Farm
    Ashford Hill
    RG15 8BN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pitt House Farm
    Ashford Hill
    RG15 8BN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish2342200001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RADIO WYVERN LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06. Apr. 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer06898191
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat RADIO WYVERN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 27. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Price
    Transaktionen
    • 27. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert John Norman
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 18. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Geoffrey Percy
    Transaktionen
    • 18. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 13. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Global Radio Group Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Philip Riley
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Antony Thomas Lloyd
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Feb. 1983
    Geliefert am 15. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 & 6 barbourne terrace worcester hereford & worcester t/n HW31289 and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    • 07. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0