CIVICA INSIGHT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CIVICA INSIGHT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01569298 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CIVICA INSIGHT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CIVICA INSIGHT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Burston Road Putney SW15 6AR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CIVICA INSIGHT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SANDERSON INSIGHT LIMITED | 17. Sept. 1992 | 17. Sept. 1992 |
| INSIGHT TERMINALS LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CIVICA INSIGHT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CIVICA INSIGHT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CIVICA INSIGHT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Juli 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Richard Downing am 04. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Phillip David Rowland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Stoddard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CIVICA INSIGHT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STODDARD, Michael | Sekretär | Walnut Cottage Main Street Hanwell OX17 1HN Banbury Oxfordshire | British | 72002400004 | ||||||
| DOWNING, Simon Richard | Geschäftsführer | 2 Burston Road Putney SW15 6AR London | England | British | 95005230002 | |||||
| ROWLAND, Phillip David | Geschäftsführer | Burston Road Putney SW15 6AR London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 147804670001 | |||||
| BRIDLE, Deborah | Sekretär | Clock Cottage Cleves Lane, Upton Grey RG25 2RG Basingstoke Hampshire | British | 75032970001 | ||||||
| FROST, Adrian David | Sekretär | 2 Edwards Road B75 5NG Sutton Coldfield West Midlands | British | 74874640001 | ||||||
| WILKINSON, Jane Allison | Sekretär | 15a Low Way LS23 6LB Clifford West Yorkshire | British | 96725700001 | ||||||
| BRIDLE, Deborah | Geschäftsführer | Clock Cottage Cleves Lane, Upton Grey RG25 2RG Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | 75032970001 | |||||
| CARROLL, Peter James | Geschäftsführer | 1 Crosslands Prestwich M25 9QT Manchester Lancashire | British | 21645790001 | ||||||
| NODEN, Philip Thomas | Geschäftsführer | Little Mill Cottage Colemere SY12 0QR Ellesmere Shropshire | British | 141537860001 | ||||||
| O'BYRNE, David Andrew | Geschäftsführer | Daisy Cottage Chapel Street Kirk Hammerton YO26 8DA York | England | British | 61632450001 | |||||
| STODDARD, Michael | Geschäftsführer | Walnut Cottage Main Street Hanwell OX17 1HN Banbury Oxfordshire | England | British | 72002400004 | |||||
| THOMPSON, Paul | Geschäftsführer | Moorgate Road S60 2AD Rotherham 41 South Yorkshire | England | British | 67791110003 | |||||
| WATSON, David John | Geschäftsführer | 151 High Street OX44 7ST Chalgrove Oxfordshire | British | 45073610001 | ||||||
| WAY, Victor | Geschäftsführer | 32 Church Road MK43 9HF Wootton Bedfordshire | United Kingdom | British | 75032960001 | |||||
| WINN, Christopher | Geschäftsführer | Willow Bank Halls Farm Lane Trimpley DY12 1NP Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 15932260001 |
Hat CIVICA INSIGHT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third guarantee & debenture between the chargor company and others and the dresdner bank ag, london branch | Erstellt am 11. Juli 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due owing or incurred by the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on or after the debenture date and under or pursuant to the mezzanine finance documents (all as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A second guarantee and debenture between, amongst others the company (being the chargor) and dresdner bank ag, london branch (as security trustee) | Erstellt am 10. März 2000 Geliefert am 21. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents and mezzanine finance documents (as therein defined), excluding from the above any liability or sum outstanding under the term facility, the loan note guarantee facility, the revolving credit facility and the mezzanine loan agreement and any other liability or sum which would, but for the proviso, cause such covenants and guarantees or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute lawful financial assistance prohibited by section 151 of the act | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. März 1997 Geliefert am 04. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 106A bedford road wootton bedford beds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Jan. 1987 Geliefert am 29. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 14. Okt. 1981 Geliefert am 19. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CIVICA INSIGHT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0