D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01570577 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Duff & Phelps Ltd The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VALAD (ENFIELD) LIMITED | 18. Sept. 2007 | 18. Sept. 2007 |
| SDG (ENFIELD) LIMITED | 26. März 2004 | 26. März 2004 |
| SCARBOROUGH DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED | 22. Aug. 2000 | 22. Aug. 2000 |
| TEESLAND DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED | 29. Sept. 1999 | 29. Sept. 1999 |
| SCARBOROUGH PROPERTY COMPANY (ESSEX) LIMITED | 01. Apr. 1996 | 01. Apr. 1996 |
| SOUTHERN & CITY (PROJECT MANAGEMENT) LIMITED | 26. Juni 1981 | 26. Juni 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 20 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 11. Mai 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 24. Feb. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Edward Maddy am 12. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Exchange Place 3 3 Semple Street EH3 8BL Edinburgh 1st Floor United Kingdom |
| 133355520004 | ||||||||||
| MADDY, James Edward | Geschäftsführer | Floor Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st United Kingdom | United Kingdom | British | 137459000002 | |||||||||
| CROMWELL DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Unit 16 Manor Court Business Park YO11 3TU Scarborough 1st Floor United Kingdom |
| 102622300003 | ||||||||||
| ARMITAGE, John Anthony | Sekretär | Leven Cottage 91 High Street Great Ayton TS9 6NF Middlesbrough Cleveland | British | 12424870001 | ||||||||||
| ASH, Christine Ann | Sekretär | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||||||
| COOPER, Hilary Joan | Sekretär | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Sekretär | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
| FRASER, Leslie Murray Fraser | Sekretär | 20 Franklin Street YO12 7JU Scarborough North Yorkshire | British | 53477320001 | ||||||||||
| HARDING, David George | Sekretär | 10 Cokeham Gardens Sompting BN15 9TB Lancing West Sussex | British | 13078050001 | ||||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Sekretär | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Sekretär | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| STEVEN, Ian William | Sekretär | 17 Buchanan Drive Bearsden G61 2EW Glasgow | British | 654410001 | ||||||||||
| ASH, Christine Ann | Geschäftsführer | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||||||
| BONNEY, Michael George | Geschäftsführer | 2 The Street Cherhill SN11 8XP Calne Wiltshire | England | British | 12424880001 | |||||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Geschäftsführer | 6 Devonshire Terrace G12 0XF Glasgow | British | 34265760001 | ||||||||||
| BURNLEY, John Lewis | Geschäftsführer | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||||||
| COOPER, Hilary Joan | Geschäftsführer | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||||||
| GOULD, Jeffery Norman | Geschäftsführer | 32 Flask Walk Hampstead NW3 1HE London | British | 69276590001 | ||||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Paul | Geschäftsführer | 2 Newdale Usher Park Haxby YO32 3LN York North Yorkshire | British | 60649820001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | 64 Clarence Road TW11 0BW Teddington Middx | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||||||
| STEVEN, Ian William | Geschäftsführer | 17 Buchanan Drive Bearsden G61 2EW Glasgow | United Kingdom | British | 654410001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Yorkshire | England | British | 69909950001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| UPTON, John Edward | Geschäftsführer | Nab End Farm Glaisdale YO21 2QA Whitby North Yorkshire | British | 13350940001 | ||||||||||
| WATTS, Alan Martin | Geschäftsführer | 20 Clareville Street SW7 5AW London | British | 55440160001 | ||||||||||
| WHITTINGTON, Christopher Mark John | Geschäftsführer | Southwood Lodge Kingsley Place Highgate N6 5EA London | United Kingdom | British | 1140780001 | |||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Manor Court Business Park Eastfield YO11 3TU Scarborough 1st Floor, Unit 16 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. März 2012 Geliefert am 30. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Part of phase 2 business innovation centre innova science park enfield t/no AGL139495 land at innova park enfield t/no AGL139495 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 28. Aug. 2009 Geliefert am 11. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juni 1996 Geliefert am 24. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as southern city (project managment) limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 4/6 bridge street congleton t/n CH313883, fixed charge all buildings and other structures, fixed charge any goodwill, fixed charge all plant machinery and other items, assigns rental income, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Feb. 1996 Geliefert am 20. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge | |
Kurze Angaben F/H-land and buildings on the north side of london road grays t/n-EX28207. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1992 Geliefert am 24. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1, 1A and 3A gas road, pontypridd, mid glamorgan. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Aug. 1991 Geliefert am 24. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £210,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H land k/a 3 market walk, hudders field, west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Feb. 1991 Geliefert am 27. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £190,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben F/H 4 and 6 bridge street congleton, cheshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of off set | Erstellt am 08. Jan. 1991 Geliefert am 24. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the e & p finance limited and/or S.C.D.O. limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben The balances of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of southern, city (project management) limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 1990 Geliefert am 05. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east side of temperance place, taff street, pontypridd, mid glamorgan. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 1990 Geliefert am 05. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2, gas road, pontypridd, taff-ely, mid. Glamorgan. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Juni 1990 Geliefert am 28. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £507,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben F/H land with the buildings erected thereon or on some part thereof & k/a 56, 57 & 58 taff street, pontypridd taff-ely district mid-glamorgan title no wa 390110. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of offset | Erstellt am 18. Apr. 1990 Geliefert am 01. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from brittains of rotherham limited brittain bros. (Rotherham) limited mckenna & brown (photo H1-F1) limited, mckenna & BRO5N limited southern city group limited southern & city developments limited, e, upton & sons PLC upton & southern holdings PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All sums which are now a which may at any time be at the credit of any account(s) in the books of the bank in the name of the company. (See from 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 1990 Geliefert am 01. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Okt. 1988 Geliefert am 15. Okt. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 17, 19 & 19A high street walton on thames title no. Sy 3168. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Aug. 1987 Geliefert am 17. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 56,57 and 58 taff street pontypridd mid glamorgan. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0