D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameD.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01570577
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VALAD (ENFIELD) LIMITED18. Sept. 200718. Sept. 2007
    SDG (ENFIELD) LIMITED26. März 200426. März 2004
    SCARBOROUGH DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED22. Aug. 200022. Aug. 2000
    TEESLAND DEVELOPMENT COMPANY (ENFIELD) LIMITED29. Sept. 199929. Sept. 1999
    SCARBOROUGH PROPERTY COMPANY (ESSEX) LIMITED01. Apr. 199601. Apr. 1996
    SOUTHERN & CITY (PROJECT MANAGEMENT) LIMITED26. Juni 198126. Juni 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    20 SeitenLIQ13

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU zum Duff & Phelps Ltd the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 11. Mai 2018

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Apr. 2018

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Notification of D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016

    24 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Valsec Director Limited am 24. Feb. 2017

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Valad Secretarial Services Limited am 24. Feb. 2017

    1 SeitenCH04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 28. Juni 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015

    24 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Edward Maddy am 12. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 10. Juli 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Exchange Place 3
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5307786
    102622300003
    ARMITAGE, John Anthony
    Leven Cottage 91 High Street
    Great Ayton
    TS9 6NF Middlesbrough
    Cleveland
    Sekretär
    Leven Cottage 91 High Street
    Great Ayton
    TS9 6NF Middlesbrough
    Cleveland
    British12424870001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Sekretär
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    HARDING, David George
    10 Cokeham Gardens
    Sompting
    BN15 9TB Lancing
    West Sussex
    Sekretär
    10 Cokeham Gardens
    Sompting
    BN15 9TB Lancing
    West Sussex
    British13078050001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Sekretär
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    STEVEN, Ian William
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Sekretär
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    British654410001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    BONNEY, Michael George
    2 The Street
    Cherhill
    SN11 8XP Calne
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    2 The Street
    Cherhill
    SN11 8XP Calne
    Wiltshire
    EnglandBritish12424880001
    BRADLEY, Pauline Anne
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    Geschäftsführer
    6 Devonshire Terrace
    G12 0XF Glasgow
    British34265760001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Geschäftsführer
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    GOULD, Jeffery Norman
    32 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    Geschäftsführer
    32 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    British69276590001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Geschäftsführer
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    STEVEN, Ian William
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    Geschäftsführer
    17 Buchanan Drive
    Bearsden
    G61 2EW Glasgow
    United KingdomBritish654410001
    TANDY, Didier Michel
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Yorkshire
    EnglandBritish69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Geschäftsführer
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    UPTON, John Edward
    Nab End Farm
    Glaisdale
    YO21 2QA Whitby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Nab End Farm
    Glaisdale
    YO21 2QA Whitby
    North Yorkshire
    British13350940001
    WATTS, Alan Martin
    20 Clareville Street
    SW7 5AW London
    Geschäftsführer
    20 Clareville Street
    SW7 5AW London
    British55440160001
    WHITTINGTON, Christopher Mark John
    Southwood Lodge Kingsley Place
    Highgate
    N6 5EA London
    Geschäftsführer
    Southwood Lodge Kingsley Place
    Highgate
    N6 5EA London
    United KingdomBritish1140780001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06. Apr. 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer4045874
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2012
    Geliefert am 30. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Part of phase 2 business innovation centre innova science park enfield t/no AGL139495 land at innova park enfield t/no AGL139495 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 30. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 28. Aug. 2009
    Geliefert am 11. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Juni 1996
    Geliefert am 24. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as southern city (project managment) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 4/6 bridge street congleton t/n CH313883, fixed charge all buildings and other structures, fixed charge any goodwill, fixed charge all plant machinery and other items, assigns rental income, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Feb. 1996
    Geliefert am 20. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    F/H-land and buildings on the north side of london road grays t/n-EX28207. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1992
    Geliefert am 24. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1, 1A and 3A gas road, pontypridd, mid glamorgan.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 1991
    Geliefert am 24. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £210,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H land k/a 3 market walk, hudders field, west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • National & Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 07. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 27. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £190,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    F/H 4 and 6 bridge street congleton, cheshire.
    Berechtigte Personen
    • National & Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 07. Dez. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of off set
    Erstellt am 08. Jan. 1991
    Geliefert am 24. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the e & p finance limited and/or S.C.D.O. limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The balances of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of southern, city (project management) limited.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Nov. 1990
    Geliefert am 05. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of temperance place, taff street, pontypridd, mid glamorgan.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Nov. 1990
    Geliefert am 05. Dez. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2, gas road, pontypridd, taff-ely, mid. Glamorgan.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1990Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1990
    Geliefert am 28. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £507,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    F/H land with the buildings erected thereon or on some part thereof & k/a 56, 57 & 58 taff street, pontypridd taff-ely district mid-glamorgan title no wa 390110.
    Berechtigte Personen
    • National & Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 28. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 30. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of offset
    Erstellt am 18. Apr. 1990
    Geliefert am 01. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from brittains of rotherham limited brittain bros. (Rotherham) limited mckenna & brown (photo H1-F1) limited, mckenna & BRO5N limited southern city group limited southern & city developments limited, e, upton & sons PLC upton & southern holdings PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All sums which are now a which may at any time be at the credit of any account(s) in the books of the bank in the name of the company. (See from 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 18. Apr. 1990
    Geliefert am 01. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 1988
    Geliefert am 15. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 17, 19 & 19A high street walton on thames title no. Sy 3168.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 07. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Aug. 1987
    Geliefert am 17. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 56,57 and 58 taff street pontypridd mid glamorgan.
    Berechtigte Personen
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Sept. 1987Registrierung einer Belastung

    Hat D.U.K.E. (ENFIELD) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Apr. 2018Beginn der Liquidation
    14. Apr. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praktiker
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0