BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01571833
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TROLHURST LIMITED01. Juli 198101. Juli 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Apr. 2016

    LRESSP
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Apr. 2016

    LRESSP

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation

    2 SeitenREST-MVL

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Ernennung von Mr Andrew William Hodges als Direktor am 30. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nicola Margaret Carroll als Geschäftsführer am 30. Juni 2016

    1 SeitenTM01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Nicola Margaret Carroll am 09. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Steven Buck als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Centrica Directors Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Ernennung von Nicola Margaret Carroll als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Bateman als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Sekretär
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    71532760003
    HODGES, Andrew William
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish77527910004
    CENTRICA DIRECTORS LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer3844287
    146695600001
    FREUDMANN, Anthony
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    Sekretär
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    British43335320001
    WHEATLEY, Trevor Neil Pearse
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    British34588420002
    ARIF, Louise
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    Geschäftsführer
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    British36425190002
    BASSIS, Anne Elizabeth
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    United KingdomAmerican/British112345920001
    BATEMAN, Matthew James
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish138280510002
    BOWTELL, John Paul Maurice
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    Geschäftsführer
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    British82969690001
    BUCK, Steven John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish96292880001
    CARROLL, Nicola
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish278861170001
    COLLIER, Edward Arthur Yarlet
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    British72213650001
    CORBETT, Michael Anthony
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    Geschäftsführer
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    British7008160003
    CORDINGLEY, Anthony Clive
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    Geschäftsführer
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    British7008170001
    DUNN, David Young
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    Geschäftsführer
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    British38982880001
    FARRAR, John Trueman
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    British34540860001
    FARROW, Dennis
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    Geschäftsführer
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    British10910860001
    FLETT, Alan Douglas
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish93037840001
    HAYWARD, Ian Charles
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    British79564240001
    KENDLE, David Philip
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish95977510001
    KENYON, Rodney Frank
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    Geschäftsführer
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    EnglandBritish62258710001
    LAIRD, James
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    Geschäftsführer
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    British34535330001
    LENHAM, Stephen
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    British7008190004
    MAXEY, Clement Leslie
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    British37195980001
    PINCHIN, Terence Rodney
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    British65159820001
    RAY, John Albert
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish104536620001
    SHAW, Daniel Rankin
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    Geschäftsführer
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    ScotlandBritish7008210001
    SHEARS, John Nicholas
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    BritishBritish61771310001
    STERN, Christopher John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    EnglandEnglish55825790001
    TURNER, Moira Lynne
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish82549950002
    UZIELLI, Michael Robin
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    British107591700002

    Hat BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Nov. 1999
    Geliefert am 26. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 320C mayoral way team valley trading estate gateshead tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Sept. 1999
    Geliefert am 30. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold - 24 hampton court king and queen wharf rotherhithe st,london SE16. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1999
    Geliefert am 10. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at unit 10 bessemer park herne hill london (leasehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Juli 1999
    Geliefert am 10. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at 239 milkwood road herne hill london (freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit agreement
    Erstellt am 05. Nov. 1998
    Geliefert am 14. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date between the landlord and the tenant relating to unit B7 the avenues team valley gateshead
    Kurze Angaben
    All the compamy's right title and interest in and to the rent deposit sum of £1,365 an all related rights thereto and thereof.
    Berechtigte Personen
    • Renbrook Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Okt. 1996
    Geliefert am 30. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the rent deposit deed
    Kurze Angaben
    Rent deposit of £1300.
    Berechtigte Personen
    • Renbrook Limited
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1996
    Geliefert am 16. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at 11 lindsay square london (leasehold) with the benefit of all rights licences guarantees and rent deposits with the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed equitable charge
    Erstellt am 17. Jan. 1996
    Geliefert am 23. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Griffin Factors Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Dez. 1995
    Geliefert am 07. Dez. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £225,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/Hold property- 11 lindsay sq,millbank,london SW1.
    Berechtigte Personen
    • Slark Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 07. Dez. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Jan. 1995
    Geliefert am 17. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a unit 12 bessemer park milkwood road herne hill london with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1994
    Geliefert am 04. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as units 22 & 23 bessemer park milkwood road herne hill london SE24 ohh. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 04. Feb. 1992
    Geliefert am 08. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 18/01/82
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital patents/applications and trade marks etc. (for full details see form 395 tc ref: M331C).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Nov. 1986
    Geliefert am 19. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    115 marsham court marsham street london.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 31. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 18. Jan. 1982
    Geliefert am 21. Jan. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book and other debts now and from time to time due floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1982Registrierung einer Belastung
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Apr. 2016Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0