BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01571833 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TROLHURST LIMITED | 01. Juli 1981 | 01. Juli 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation | 2 Seiten | REST-MVL | ||||||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew William Hodges als Direktor am 30. Juni 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicola Margaret Carroll als Geschäftsführer am 30. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicola Margaret Carroll am 09. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Buck als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Centrica Directors Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||||||
Ernennung von Nicola Margaret Carroll als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Bateman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRICA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | 71532760003 | |||||||||||
| HODGES, Andrew William | Geschäftsführer | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 77527910004 | |||||||||
| CENTRICA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire United Kingdom |
| 146695600001 | ||||||||||
| FREUDMANN, Anthony | Sekretär | 15 Lings Coppice SE21 8SY London | British | 43335320001 | ||||||||||
| WHEATLEY, Trevor Neil Pearse | Sekretär | 28 St Johns Hill SY1 1JJ Shrewsbury Shropshire | British | 34588420002 | ||||||||||
| ARIF, Louise | Geschäftsführer | 7 Wolfe Crescent Surrey Quays SE16 1SF London | British | 36425190002 | ||||||||||
| BASSIS, Anne Elizabeth | Geschäftsführer | Harcourt Terrace SW10 9JP London 75 Greater London United Kingdom | United Kingdom | American/British | 112345920001 | |||||||||
| BATEMAN, Matthew James | Geschäftsführer | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 138280510002 | |||||||||
| BOWTELL, John Paul Maurice | Geschäftsführer | Hallam Sampford Road CB10 2TL Radwinter Essex | British | 82969690001 | ||||||||||
| BUCK, Steven John | Geschäftsführer | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 96292880001 | |||||||||
| CARROLL, Nicola | Geschäftsführer | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 278861170001 | |||||||||
| COLLIER, Edward Arthur Yarlet | Geschäftsführer | Whitehill Close Old Whitehill OX5 3AB Tackley Oxfordshire | British | 72213650001 | ||||||||||
| CORBETT, Michael Anthony | Geschäftsführer | 6 Keasden Avenue FY4 3JF Blackpool Lancashire | British | 7008160003 | ||||||||||
| CORDINGLEY, Anthony Clive | Geschäftsführer | Wildhern 28 St Martins Drive Eynsford DA4 0EZ Dartford Kent | British | 7008170001 | ||||||||||
| DUNN, David Young | Geschäftsführer | 2 Glendarvel Avenue Bearsden G61 2PR Glasgow | British | 38982880001 | ||||||||||
| FARRAR, John Trueman | Geschäftsführer | Hillview House Park Close KT22 9BD Leatherhead Surrey | British | 34540860001 | ||||||||||
| FARROW, Dennis | Geschäftsführer | 30 Montpelier Gardens East Ham E6 3JD London | British | 10910860001 | ||||||||||
| FLETT, Alan Douglas | Geschäftsführer | 16 Guards Court Chobham Road Ascot SL5 0ES Sunningdale Berkshire | England | British | 93037840001 | |||||||||
| HAYWARD, Ian Charles | Geschäftsführer | 9 Wilderness Road RG6 7RU Reading Berkshire | British | 79564240001 | ||||||||||
| KENDLE, David Philip | Geschäftsführer | 99 Higher Drive SM17 1PS Banstead Surrey | United Kingdom | British | 95977510001 | |||||||||
| KENYON, Rodney Frank | Geschäftsführer | 62 Chiswick Green Studios Evershed Walk Chiswick W4 5BW London | England | British | 62258710001 | |||||||||
| LAIRD, James | Geschäftsführer | 17 Morlich Road Dalgety Bay KY11 5UF Dunfermline Fife | British | 34535330001 | ||||||||||
| LENHAM, Stephen | Geschäftsführer | 17 High Beeches SM7 1NB Banstead Surrey | British | 7008190004 | ||||||||||
| MAXEY, Clement Leslie | Geschäftsführer | 4 Formby Close Belton Lane NG31 9PD Grantham Lincolnshire | British | 37195980001 | ||||||||||
| PINCHIN, Terence Rodney | Geschäftsführer | 2 St Judes Close Englefield Green TW20 0DE Egham Surrey | British | 65159820001 | ||||||||||
| RAY, John Albert | Geschäftsf ührer | Woodbrook Beech Drive KT20 6PJ Kingswood Surrey | United Kingdom | British | 104536620001 | |||||||||
| SHAW, Daniel Rankin | Geschäftsführer | Lindenlee Old Greenock Road PA7 5PA Bishopton Renfrewshire | Scotland | British | 7008210001 | |||||||||
| SHEARS, John Nicholas | Geschäftsführer | Lovania Birch Lane SL5 8RF Ascot Berkshire | British | British | 61771310001 | |||||||||
| STERN, Christopher John | Geschäftsführer | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | England | English | 55825790001 | |||||||||
| TURNER, Moira Lynne | Geschäftsführer | Woodend House 11 Dower Close HP9 1XZ Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 82549950002 | |||||||||
| UZIELLI, Michael Robin | Geschäftsführer | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | British | 107591700002 |
Hat BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Nov. 1999 Geliefert am 26. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 320C mayoral way team valley trading estate gateshead tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Sept. 1999 Geliefert am 30. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold - 24 hampton court king and queen wharf rotherhithe st,london SE16. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Juli 1999 Geliefert am 10. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property at unit 10 bessemer park herne hill london (leasehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Juli 1999 Geliefert am 10. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property at 239 milkwood road herne hill london (freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit agreement | Erstellt am 05. Nov. 1998 Geliefert am 14. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date between the landlord and the tenant relating to unit B7 the avenues team valley gateshead | |
Kurze Angaben All the compamy's right title and interest in and to the rent deposit sum of £1,365 an all related rights thereto and thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 14. Okt. 1996 Geliefert am 30. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the rent deposit deed | |
Kurze Angaben Rent deposit of £1300. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. März 1996 Geliefert am 16. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property at 11 lindsay square london (leasehold) with the benefit of all rights licences guarantees and rent deposits with the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed equitable charge | Erstellt am 17. Jan. 1996 Geliefert am 23. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Dez. 1995 Geliefert am 07. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £225,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/Hold property- 11 lindsay sq,millbank,london SW1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1995 Geliefert am 17. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a unit 12 bessemer park milkwood road herne hill london with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1994 Geliefert am 04. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/as units 22 & 23 bessemer park milkwood road herne hill london SE24 ohh. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 04. Feb. 1992 Geliefert am 08. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 18/01/82 | |
Kurze Angaben First fixed charge on all goodwill uncalled capital patents/applications and trade marks etc. (for full details see form 395 tc ref: M331C). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 1986 Geliefert am 19. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 115 marsham court marsham street london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 18. Jan. 1982 Geliefert am 21. Jan. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book and other debts now and from time to time due floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0