HOVERSPEED (1981) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHOVERSPEED (1981) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01572431
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HOVERSPEED (1981) LIMITED?

    • (6110) /

    Wo befindet sich HOVERSPEED (1981) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Hill House
    BH2 6HR Richmond Hill
    Bournemouth
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HOVERSPEED (1981) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INTERCEDE FIFTY-FOUR LIMITED06. Juli 198106. Juli 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOVERSPEED (1981) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für HOVERSPEED (1981) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2010

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Jan. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Jan. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    6 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Vermögensübersicht

    16 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    legacy

    1 Seiten244

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    14 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von HOVERSPEED (1981) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RICHARDS, Jeffrey Richard
    8 Smiths Field
    Cupernham Lane
    SO51 7WD Romsey
    Hampshire
    Sekretär
    8 Smiths Field
    Cupernham Lane
    SO51 7WD Romsey
    Hampshire
    BritishCompany Director35997870001
    BENSON, David Gillies
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Ducks Farm
    Eastcott
    SN10 4PJ Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director1856390001
    CLARK, Paul Andrew
    Villa Marina
    12 Sea Front Road
    PE25 3BQ Skegness
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Villa Marina
    12 Sea Front Road
    PE25 3BQ Skegness
    Lincolnshire
    BritishAccountant81036490001
    EDE, Geoffrey Leslie
    8 Lees Court
    Sheldwich Lees
    ME13 0NQ Faversham
    Kent
    Geschäftsführer
    8 Lees Court
    Sheldwich Lees
    ME13 0NQ Faversham
    Kent
    BritishManaging Director120084520001
    CRINKS, Francis William
    27 Hillcrest Road
    CT21 5EU Hythe
    Kent
    Sekretär
    27 Hillcrest Road
    CT21 5EU Hythe
    Kent
    British28004100001
    WALLER, Paul Reginald
    29 Island Road
    Sturry
    CT2 0EB Canterbury
    Kent
    Sekretär
    29 Island Road
    Sturry
    CT2 0EB Canterbury
    Kent
    British59710180001
    MOSES, William Trevor
    Cumulus 56 Bramley Avenue
    ME13 8LP Faversham
    Kent
    Geschäftsführer
    Cumulus 56 Bramley Avenue
    ME13 8LP Faversham
    Kent
    BritishManaging Director8301870001
    WALKER, Peter Colin
    Home Farm House Easole Street
    Nonington
    CT15 4HG Dover
    Kent
    Geschäftsführer
    Home Farm House Easole Street
    Nonington
    CT15 4HG Dover
    Kent
    EnglandEnglishChartered Accountant59076670002

    Hat HOVERSPEED (1981) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and indemnity
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Authorises the security trustee to enforce this guarantee against any credit balance from time to time standing to the credit of any of the company's accounts with any branch of the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest to the insurances, the earnings and the requisition compensation in respect of M.V. "rapide".
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest to the insurances, the earnings and the requisition compensation in respect of M.V. "diamant".
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of covenants
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The motor vessel "rapide" official no 729622 together with all her engines, machinery, boats, tackle, outfit, fuels, spares, consumable and other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of covenants
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The motor vessel "diamant" official no 728143 together with all her engines, machinery, boats, tackle, outfit, fuels, spares, consumable and other stores, belongings and appurtenances whether on board or ashore. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    First priority mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the motor vessel "diamant" official no 728142 together with all her boats, guns, ammunition, small arms and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    First priority mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the motor vessel "rapide" official no 729622 together with all her boats, guns, ammunition, small arms and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment and priority agreement
    Erstellt am 27. März 2001
    Geliefert am 06. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The aggregate of all amounts due or to become due from time to time or at any time from sea containers italia S.R.L. ("sci") and/or the owners to the chargee under the terms of a guarantee facility agreement dated 28TH may 1997 as novated, amended and restated by a single deed dated 27TH may 2001 and/or under the security documents (as defined in the assignment and priority agreement) and/or in connection therewith.
    Kurze Angaben
    The company's right, title and interest in all freight, ticket monies, hire and any other amounts whatsoever which may at any time be earned by or become payable to or for the account of the assignors or their agents arising out of or as a result of the ownership, possession, management and/or operation of the M.V. "superseacat one" ("the ship"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 25. Feb. 1983
    Geliefert am 17. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies secured by a mortgage debenture dated 28.10.81 three separate deeds of mortgage and charge dated 29.10.81 & a deed of mortgage & charge dated 28.10.82 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1983Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 28. Okt. 1982
    Geliefert am 15. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hoverspeed (UK) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the owners rights, interest and property in the hovercraft srn 4 mark 2 named "prince of wales" registered in london under no gh 2054 floating charge over all the said craft and all equipment spare parts, gear and appurtenances present and future.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 29. Okt. 1981
    Geliefert am 07. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hoverspeed (u k) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    A) all the owners right interest and property in hovercraft type srn 4 mark 2 named "sure" registered number gh 2005 b) the earnings in respect of the said craft c) the insurnaces in respect of the said craft d) requisition compensation in respect of the said craft. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 29. Okt. 1981
    Geliefert am 07. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hoverspeed (UK) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    A) all the owners right interest and property in hovercraft srn 4 mark 2 named "the prince of wales" registered number gh 2054 b) the earnings of the said craft c) the insurance of the said craft d) requisition compensation relating to the said craft. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 29. Okt. 1981
    Geliefert am 07. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hoverspeed (u k) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    A) all the companys rights interest and property in hovercraft type srn 4 mark 2 named swift registered number gh 2004 b) the earnings in respect of the said craft. C) the insurances in respect of the said craft d) requistion compensation in respect of the said craft. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 29. Okt. 1981
    Geliefert am 07. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and hoverspeed (u k ) limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A) all the companys right interest and property in hovercraft type srn 4 mark 2 named sir christopher registered number gh 2008 b) all earnings in respect thereof c) the insurances thereof. D) requistion compensation relating to the said hovercraft. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 28. Okt. 1981
    Geliefert am 11. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies as outlined on form 47. (see M22)
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • British Rail Hovercraft LTD
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 28. Okt. 1981
    Geliefert am 10. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from hoverspeed (k) limited to the chargee under the terms of the agreement dated 28/10/81
    Kurze Angaben
    Fixed & floating on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Hoverlloyd Limited
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Okt. 1981
    Geliefert am 06. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over the company's f/h or l/h properties fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    • 14. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HOVERSPEED (1981) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. Mai 2012Aufgelöst am
    31. Jan. 2006Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Russell Downs
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Hill House
    BH2 6HR Richmond Hill
    Bournemouth
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Hill House
    BH2 6HR Richmond Hill
    Bournemouth
    Ian C. Oakley-Smith
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0