HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED

HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHODGSON & HODGSON GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01574452
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    • Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Sonstige Herstellung n.e.c. (32990) / Verarbeitendes Gewerbe
    • Boden- und Wandverkleidung (43330) / Bauwesen
    • Umweltberatungsaktivitäten (74901) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OAKTIME LIMITED15. Juli 198115. Juli 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2020

    23 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2019

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2018

    24 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    31 SeitenAM22

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    38 SeitenAM10

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    62 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    18 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 15 the Crown Business Park, Station Road Old Dalby Melton Mowbray Leicestershire LE14 3NQ zum 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 27. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 015744520013, erstellt am 03. Aug. 2016

    18 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 015744520016, erstellt am 03. Aug. 2016

    15 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 015744520014, erstellt am 03. Aug. 2016

    17 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 015744520015, erstellt am 03. Aug. 2016

    15 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    26 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 08. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 139,433.75
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Paul David Pickup am 01. Sept. 2015

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Crown Industrial Estate Anglesey Road Burton-on-Trent Staffordshire DE14 3PA zum Unit 15 the Crown Business Park, Station Road Old Dalby Melton Mowbray Leicestershire LE14 3NQ am 01. Sept. 2015

    1 SeitenAD01

    Eintragung der Belastung 015744520011, erstellt am 08. Juli 2015

    17 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 015744520012, erstellt am 08. Juli 2015

    17 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PICKUP, Paul David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Sekretär
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    British11661720003
    GREEN, Kevin Jeffrey
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish83354170002
    LOFTUS, Gerard
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish199232130001
    PICKUP, Paul David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish11661720003
    WEAVERS, Paul Barrington
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish63246890002
    WOOD, Martin Charles
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish102354760001
    HOBBS, Philip
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    British25400000001
    PICKUP, Paul David
    46 Hazelbank Avenue
    Mapperley
    NG3 3EY Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    46 Hazelbank Avenue
    Mapperley
    NG3 3EY Nottingham
    Nottinghamshire
    British11661720002
    WHITE, John Michael
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    British16842280001
    BALSHAW JONES, Glynne
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish52751310002
    COMANDI, Juan Manuel
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish117153380001
    DOYLE, Thomas John
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish159373190001
    GRUNDY, Nigel Arthur
    The Crofts
    CO6 4QY Stoke-By-Nayland
    Suffolk
    Geschäftsführer
    The Crofts
    CO6 4QY Stoke-By-Nayland
    Suffolk
    United KingdomBritish6498450001
    HOBBS, Philip
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish25400000001
    HUGO, Gerald William
    55 Denton Road
    DE13 0QA Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    55 Denton Road
    DE13 0QA Burton On Trent
    Staffordshire
    British16842290001
    LONG, Brian Thomas
    258 Rolleston Road
    DE13 0AY Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    258 Rolleston Road
    DE13 0AY Burton On Trent
    Staffordshire
    British16842300002
    NARBURGH, Margaret
    Plas Pinwydden
    Village Road Maeshafn
    CH7 5LU Mold
    Denbighshire
    Geschäftsführer
    Plas Pinwydden
    Village Road Maeshafn
    CH7 5LU Mold
    Denbighshire
    British83189380001
    PROFIT, John Anthony
    8 Tanwood Close
    B91 3JX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    8 Tanwood Close
    B91 3JX Solihull
    West Midlands
    British69219120001
    ROBERTS, John
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish32341560001
    ROLLINSON, Philip
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish21921610001
    WHITE, John Michael
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    British16842280001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Wrogel Management Ltd
    Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    England
    06. Apr. 2016
    Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer09353662
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Aug. 2016
    Geliefert am 04. Aug. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freehold property known as 15 princewood road, corby described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby being the land registered with title number NN130556.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wrogel Management Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Aug. 2016
    Geliefert am 04. Aug. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freehold land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Wrogel Management Limited
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Aug. 2016
    Geliefert am 04. Aug. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freeland land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Gerard Christopher Loftus
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Aug. 2016
    Geliefert am 04. Aug. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freehold property known as 15 princewood road, corby NN17 4AP (described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby NN17 4AP) with title number NN130556.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Gerard Christopher Loftus
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juli 2015
    Geliefert am 21. Juli 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The freehold property known as 15 princewood road, corby described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby being the land registered with title number NN130556.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Gerard Christopher Loftus
    Transaktionen
    • 21. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juli 2015
    Geliefert am 21. Juli 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Freehold land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Gerard Christopher Loftus
    Transaktionen
    • 21. Juli 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2010
    Geliefert am 02. Juli 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Close Invoice Finance LTD
    Transaktionen
    • 02. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 23. Juni 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as unit 14 sceptre road, crown business park, old dalby, melton mowbray, leicestershire LE14 3NQ t/no: LT308365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as aldham house, 41A lady lane industrial estate, hadleigh t/no: SK119826. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2000
    Geliefert am 04. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 23 (formerly 15) princewood road, earlstree industrial estate, corby, northamptonshire t/no: NN130556. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 12. März 2000
    Geliefert am 21. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor (as defined) to the chargee on any account whatsoever and incurred under any finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transaktionen
    • 21. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 1997
    Geliefert am 09. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Okt. 1985
    Geliefert am 14. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charge over:- goodwill, bookdebts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    • 31. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 1982
    Geliefert am 28. Jan. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Estate Duties Investments Trust P.L.C.
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1982Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 15. Jan. 1982
    Geliefert am 28. Jan. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Okt. 2016Beginn der Verwaltung
    29. Juni 2017Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2
    DatumTyp
    29. Juni 2017Beginn der Liquidation
    18. Aug. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0