CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP

CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 01580263
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP LIMITED13. Dez. 199413. Dez. 1994
    TIPHOOK PLC14. Mai 198514. Mai 1985
    TIPHOOK HOLDINGS LIMITED26. Nov. 198226. Nov. 1982
    PACEYARD LIMITED14. Aug. 198114. Aug. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT zum 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT geändert

    2 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT verlegt

    2 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 13. Okt. 2020

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Sept. 2020

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Sept. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Thomas Peter Budge als Geschäftsführer am 11. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Akhlesh Prasad Mathur als Geschäftsführer am 11. Juni 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    24 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reg registered 16/09/2019
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Zustimmung zur Umwandlung

    1 SeitenFOA-RR

    Bescheinigung über die Umregistrierung von beschränkt haftend in unbeschränkt haftend

    1 SeitenCERT3

    Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung

    37 SeitenMAR

    Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung

    2 SeitenRR05

    Notification of Ge Capital International Holdings Limited as a person with significant control on 13. Sept. 2019

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Ige Usa Investments Limited as a person with significant control on 13. Sept. 2019

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. Sept. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Akhlesh Prasad Mathur am 01. Aug. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Thomas Peter Budge am 01. Aug. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Shahryar Mufti am 01. Aug. 2019

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomMaltese228824220001
    MUFTI, Shahryar
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish215531750001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Sekretär
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Sekretär
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Sekretär
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Sekretär
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    ANDREW, Jonathan
    The Malt House
    Grove End
    OX15 5BA Upper Brailes
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Malt House
    Grove End
    OX15 5BA Upper Brailes
    Oxfordshire
    British88713160001
    ASHTON, Richard
    Quinten Massigstraat 2-7
    FOREIGN Amsterdam
    1077mc
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Quinten Massigstraat 2-7
    FOREIGN Amsterdam
    1077mc
    The Netherlands
    British74196630001
    BARNETT, Rick
    57 Stones Drive
    Ripponden
    HX6 4NY Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    57 Stones Drive
    Ripponden
    HX6 4NY Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British62374150002
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    BRADLEY, Todd
    20336 Wallingford Lane Barrington
    Illinois 60010
    FOREIGN Usa
    Geschäftsführer
    20336 Wallingford Lane Barrington
    Illinois 60010
    FOREIGN Usa
    American55926160001
    BRAIDWOOD, Rodger Gordon
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    Geschäftsführer
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    EnglandBritish1484600001
    BUCCI, John Vincent
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Summerhill
    Steels Lane, Oxshott
    KT22 0QQ Leatherhead
    Surrey
    America81623160001
    BUDGE, Andrew Thomas Peter
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United KingdomBritish182363660001
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Church Barn House Church End
    MK40 4AS Biddenham
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Church Barn House Church End
    MK40 4AS Biddenham
    Bedfordshire
    EnglandBritish239557120001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Geschäftsführer
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Geschäftsführer
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    CROWTHER, Jonathan Michael
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Wheatley Rise
    LS29 8SQ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish49068160001
    DICK, John Kenneth
    Overbye
    Church Street
    KT11 3EG Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Overbye
    Church Street
    KT11 3EG Cobham
    Surrey
    British1484610001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Geschäftsführer
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritish45623310001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HAMBRO, Rupert Nicholas
    186 Ebury Street
    SW1W 8UP London
    Geschäftsführer
    186 Ebury Street
    SW1W 8UP London
    EnglandBritish74481160001
    HODGKISS, Roger Hilton
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    Geschäftsführer
    The Old Stables Ingthorne Lane
    South Milford
    LS25 5DH Leeds
    United KingdomBritish76993260001
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    KOHLHAUSSEN, Martin, Dr
    Am Rabenstein 7
    Bad Homburg
    Hessen 61350
    Germany
    Geschäftsführer
    Am Rabenstein 7
    Bad Homburg
    Hessen 61350
    Germany
    German85199450001
    MATHUR, Akhlesh Prasad
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United KingdomBritish199428980002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OLIVER, John Lancaster
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    Geschäftsführer
    Muhlgasse 11
    Berg
    Bayern 82335
    Germany
    British87846400001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    British4764800001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    13. Sept. 2019
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer9666321
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    26. Juli 2017
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3255766
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    12. Sept. 201601. Dez. 2017Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1996
    Geliefert am 30. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 30. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 24. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter indemnity dated 4/10/90 and/or this charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 24. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter indemnity dated 17/11/88 and/or this charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's acount numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 24. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter-indemnity dated 18/4/90 and/or this charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 24. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter-indemnity dated 17/11/88 and or this charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 24. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a counter-indemnity dated 30TH august 1990 in respect of a guarantee dated 5TH september 1990 and this deed (as defined therein)
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to account no: 9834362 held with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 23. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a facility letter dated 14TH january 1991 and this deed (as defined therein)
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653110 and 7943377. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank A.G. London Branch
    Transaktionen
    • 23. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 23. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of an indemnity contained in an uncommitted multiple facility agreement dated 24TH july 1991 and this deed (as defined therein)
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the company's account no.5487913 Including the balance standing to the credit of the account.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 23. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 23. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee dated 30TH april 1992 and this deed (as defined therein)
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653153 and 7943393. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 21. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the said agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined Therein) or the Banks (as Defined in the Credit Agreement Dated 13TH February 1994)
    Transaktionen
    • 21. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 01. Mai 1992
    Geliefert am 22. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 09/04/92
    Kurze Angaben
    The equipment purchased as defined on form 395 ref:245.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 1988
    Geliefert am 03. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge l/h property k/a 2ND floor flat 83 widmore road bromley kent title no sgl 1 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Scotiabank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 1988
    Geliefert am 03. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all that f/h land situate at and k/a 83 widmore road bromley kent title no K219640 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Scotiabank (UK) Limited
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Feb. 1988
    Geliefert am 25. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter date 10/2/88 and/or this charge
    Kurze Angaben
    All frieght containers (the equipment) as described in the schedule to the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Copenhagen Handels Bank a/S
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memo. Repeat of east deposits
    Erstellt am 23. Dez. 1987
    Geliefert am 11. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The amount of us dollars 6,000,000,00 depositor with the chargee etc (see form 395 M449/jan 13/cf for details).
    Berechtigte Personen
    • Commerybank Aktingesellaschaft
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    Gurantee & debenture
    Erstellt am 02. Nov. 1984
    Geliefert am 21. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 1984Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Nov. 1983
    Geliefert am 17. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    04 and/or tiphook container leasing co. Limited
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1982
    Geliefert am 05. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies or to become due from pearlbury limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 1/11/82
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts, uncalled capital, all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all stocks, shars, and other securities.
    Berechtigte Personen
    • United Kingdom Temperance and General Provident Institution
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Sept. 2020Beginn der Liquidation
    13. Okt. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0