CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP
Überblick
| Unternehmensname | CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 01580263 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP LIMITED | 13. Dez. 1994 | 13. Dez. 1994 |
| TIPHOOK PLC | 14. Mai 1985 | 14. Mai 1985 |
| TIPHOOK HOLDINGS LIMITED | 26. Nov. 1982 | 26. Nov. 1982 |
| PACEYARD LIMITED | 14. Aug. 1981 | 14. Aug. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT zum 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 13. Okt. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Sept. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Thomas Peter Budge als Geschäftsführer am 11. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Akhlesh Prasad Mathur als Geschäftsführer am 11. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 24 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Zustimmung zur Umwandlung | 1 Seiten | FOA-RR | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von beschränkt haftend in unbeschränkt haftend | 1 Seiten | CERT3 | ||||||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 37 Seiten | MAR | ||||||||||||||
Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung | 2 Seiten | RR05 | ||||||||||||||
Notification of Ge Capital International Holdings Limited as a person with significant control on 13. Sept. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Ige Usa Investments Limited as a person with significant control on 13. Sept. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Akhlesh Prasad Mathur am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Thomas Peter Budge am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Shahryar Mufti am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GATT, Jonathan Lawrence John | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | Maltese | 228824220001 | |||||||||
| MUFTI, Shahryar | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 215531750001 | |||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Sekretär | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| PRICE, Philip Ian | Sekretär | 4 Queenswood Avenue Hutton CM13 1HR Brentwood Essex | British | 75578650002 | ||||||||||
| SMITH, Nicholas Handran | Sekretär | Flat 2 19 Netherhall Gardens NW3 5RL Hampstead London | Australian | 50914130001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
| TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
| ANDREW, Jonathan | Geschäftsführer | The Malt House Grove End OX15 5BA Upper Brailes Oxfordshire | British | 88713160001 | ||||||||||
| ASHTON, Richard | Geschäftsführer | Quinten Massigstraat 2-7 FOREIGN Amsterdam 1077mc The Netherlands | British | 74196630001 | ||||||||||
| BARNETT, Rick | Geschäftsführer | 57 Stones Drive Ripponden HX6 4NY Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 62374150002 | ||||||||||
| BEADLE, Paul Laurence | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | United Kingdom | British | 100238650001 | |||||||||
| BRADLEY, Todd | Geschäftsführer | 20336 Wallingford Lane Barrington Illinois 60010 FOREIGN Usa | American | 55926160001 | ||||||||||
| BRAIDWOOD, Rodger Gordon | Geschäftsführer | Abbotsleigh Rosecroft Park Farnham Lane TN3 0DZ Langton Green Kent | England | British | 1484600001 | |||||||||
| BUCCI, John Vincent | Geschäftsführer | Summerhill Steels Lane, Oxshott KT22 0QQ Leatherhead Surrey | America | 81623160001 | ||||||||||
| BUDGE, Andrew Thomas Peter | Geschäftsführer | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire | United Kingdom | British | 182363660001 | |||||||||
| BURNS, Bernard Kenneth Robbie | Geschäftsführer | Church Barn House Church End MK40 4AS Biddenham Bedfordshire | England | British | 239557120001 | |||||||||
| CAKEBREAD, David | Geschäftsführer | The Quadrant Aztec West BS32 4GQ Bristol 2630 United Kingdom | United Kingdom | British | 183172770001 | |||||||||
| CHANDLER, Andrew Philip | Geschäftsführer | 66 Baywell Leybourne ME19 5QQ West Malling Kent | British | 53832740001 | ||||||||||
| CITRON, Zachary Joseph | Geschäftsführer | 23 Holders Hill Crescent NW14 1NE London | British | 91783950001 | ||||||||||
| CLARK, Roy Graham | Geschäftsführer | 18 Rosary Gardens SW7 4NT London | British | 65257100001 | ||||||||||
| CLUBB, Ian Mcmaster | Geschäftsführer | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | 3485960001 | ||||||||||
| CROWTHER, Jonathan Michael | Geschäftsführer | 11 Wheatley Rise LS29 8SQ Ilkley West Yorkshire | England | British | 49068160001 | |||||||||
| DICK, John Kenneth | Geschäftsführer | Overbye Church Street KT11 3EG Cobham Surrey | British | 1484610001 | ||||||||||
| GOODWIN, Eric | Geschäftsführer | Brewers Wood Pondfield Lane Shorne DA12 3LD Gravesend Kent | England | British | 45623310001 | |||||||||
| GREEN, Pamela Anne | Geschäftsführer | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
| HAMBRO, Rupert Nicholas | Geschäftsführer | 186 Ebury Street SW1W 8UP London | England | British | 74481160001 | |||||||||
| HODGKISS, Roger Hilton | Geschäftsführer | The Old Stables Ingthorne Lane South Milford LS25 5DH Leeds | United Kingdom | British | 76993260001 | |||||||||
| HOWELL, David | Geschäftsführer | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | 109591300001 | |||||||||
| KOHLHAUSSEN, Martin, Dr | Geschäftsführer | Am Rabenstein 7 Bad Homburg Hessen 61350 Germany | German | 85199450001 | ||||||||||
| MATHUR, Akhlesh Prasad | Geschäftsführer | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire | United Kingdom | British | 199428980002 | |||||||||
| MONTAGUE, Robert Joel | Geschäftsführer | Pusey House SN7 8QB Pusey Oxfordshire | British | 65130630002 | ||||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Geschäftsführer | Muhlgasse 11 Berg Bayern 82335 Germany | British | 87846400001 | ||||||||||
| PALMER, Christopher Antony | Geschäftsführer | Church Farm East Woodhay RG20 0AL Newbury Berkshire | British | 4764800001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Capital International Holdings Limited | 13. Sept. 2019 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Ige Usa Investments Limited | 26. Juli 2017 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 12. Sept. 2016 | 01. Dez. 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 1996 Geliefert am 30. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 24. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter indemnity dated 4/10/90 and/or this charge | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 24. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter indemnity dated 17/11/88 and/or this charge | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the company's acount numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 24. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a counter-indemnity dated 18/4/90 and/or this charge | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank (blsa) limited at po box 545 faryners house london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 24. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a counter-indemnity dated 17/11/88 and or this charge | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the company's account numbered 9834362 held with lloyds bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 24. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a counter-indemnity dated 30TH august 1990 in respect of a guarantee dated 5TH september 1990 and this deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to account no: 9834362 held with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a facility letter dated 14TH january 1991 and this deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653110 and 7943377. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of an indemnity contained in an uncommitted multiple facility agreement dated 24TH july 1991 and this deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the company's account no.5487913 Including the balance standing to the credit of the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee dated 30TH april 1992 and this deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to both and each of the company's accounts no: 76653153 and 7943393. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 21. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the said agreement and a guarantee dated 15TH march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 01. Mai 1992 Geliefert am 22. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 09/04/92 | |
Kurze Angaben The equipment purchased as defined on form 395 ref:245. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Okt. 1988 Geliefert am 03. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge l/h property k/a 2ND floor flat 83 widmore road bromley kent title no sgl 1 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Okt. 1988 Geliefert am 03. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all that f/h land situate at and k/a 83 widmore road bromley kent title no K219640 for more details see doc 395 ref M62 date 4/11. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Feb. 1988 Geliefert am 25. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter date 10/2/88 and/or this charge | |
Kurze Angaben All frieght containers (the equipment) as described in the schedule to the mortgage. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memo. Repeat of east deposits | Erstellt am 23. Dez. 1987 Geliefert am 11. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The amount of us dollars 6,000,000,00 depositor with the chargee etc (see form 395 M449/jan 13/cf for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Gurantee & debenture | Erstellt am 02. Nov. 1984 Geliefert am 21. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Nov. 1983 Geliefert am 17. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag 04 and/or tiphook container leasing co. Limited | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Nov. 1982 Geliefert am 05. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies or to become due from pearlbury limited to the chargee under the terms of a loan agreement dated 1/11/82 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts, uncalled capital, all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all stocks, shars, and other securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CENTRAL TRANSPORT RENTAL GROUP Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0