WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01580744 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WESTMINSTER HEALTH CARE HOLDINGS PLC | 16. Okt. 1992 | 16. Okt. 1992 |
| NME (UK) LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
| MILVERSTEAD LIMITED | 17. Aug. 1981 | 17. Aug. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 015807440009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 015807440010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Okt. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Hather als Geschäftsführer am 14. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Michael Patrick O'reilly als Sekretär am 03. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Michael Patrick O'reilly als Direktor am 03. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Dr Mark Antony Hazlewood am 27. Feb. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr Pete Calveley am 28. Feb. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 304, Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour London SW10 0XF zum 3rd Floor the Aspect Finsbury Square London EC2A 1AS am 08. März 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Portal als Sekretär am 05. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian John Portal als Geschäftsführer am 05. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 015807440010, erstellt am 01. Aug. 2016 | 46 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian John Portal am 01. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Ian Portal am 01. Aug. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'REILLY, Michael Patrick | Sekretär | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | 230771860001 | |||||||
| CALVELEY, Pete | Geschäftsführer | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 188462950001 | |||||
| HAZLEWOOD, Dr Mark Antony, Dr | Geschäftsführer | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 186525550001 | |||||
| O'REILLY, Michael Patrick | Geschäftsführer | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 40241900001 | |||||
| HATHER, Jon | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||
| HAYTER, Alan Henry | Sekretär | Birchlands Milland GU30 7LU Liphook Hants | British | 212050001 | ||||||
| O'CONNELL, Kevin Daniel | Sekretär | 27 Stag Green Avenue AL9 5EB Hatfield Hertfordshire | English | 15336730002 | ||||||
| PORTAL, Ian | Sekretär | Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 304, United Kingdom | 165321850001 | |||||||
| PURSE, Stephen John | Sekretär | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | British | 58759290001 | ||||||
| ARGENT, Malcolm, Mr. | Geschäftsführer | Chestnuts Fryerning Lane Fryerning CM4 0DF Ingatestone Essex | England | British | 32104000002 | |||||
| BRADFORD, Martin Major, Mr. | Geschäftsführer | 10 Edenhurst Avenue SW6 3PB London | England | British | 9565360001 | |||||
| CARTER, Patrick Robert, Lord | Geschäftsführer | 60 Hamilton Park West N5 1AB London | United Kingdom | British | 6338850001 | |||||
| DUNCAN, David Gregor | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 97755760001 | |||||
| EASTERMAN, Philip Harry | Geschäftsführer | 3 Oakview Hyde Heath HP6 5SE Amersham Buckinghamshire | British | 63476990001 | ||||||
| FRASER, John Stewart | Geschäftsführer | The Lodge Forest Place Waldron TN21 0TG Heathfield East Sussex | Australian | 2040370008 | ||||||
| HATHER, Jon | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 68848420006 | |||||
| HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| LOCKHART, John William | Geschäftsführer | The Old Vicarage Furneux Pelham SG9 0LD Buntingford Hertfordshire | United Kingdom | British | 83102020001 | |||||
| MAYEUX, David Russell | Geschäftsführer | 11798 E Pradera Road Camarillo California 93102 Usa | Usa | 33851390001 | ||||||
| MCGARTOLL, Owen Raphael | Geschäftsführer | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | 116537370001 | ||||||
| MITCHELL, Nick | Geschäftsführer | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield | Englsih | 92869540001 | ||||||
| PARSONS, Michael Dennis | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 44895330007 | |||||
| PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr | Geschäftsführer | The Thatched House Manor Way Oxshott KT22 0HU Leatherhead Surrey | British | 63915280001 | ||||||
| PHIPPEN, Kent William | Geschäftsführer | 35 Singleton Scarp Woodside Park N12 7AR London | American | 36778230001 | ||||||
| PORTAL, Ian John | Geschäftsführer | Third Floor, Design Centre East Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 304, United Kingdom | United Kingdom | British | 165696110001 | |||||
| POWERS, Marcus Eugene | Geschäftsführer | 2700 Colorado Avenue FOREIGN Santa Monica California Usa | American | 10334030001 | ||||||
| PURSE, Stephen John | Geschäftsführer | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | England | British | 58759290001 | |||||
| SCOTT, Iain John Gosman | Geschäftsführer | 37 Midmills Road IV2 3NZ Inverness Inverness Shire | Scotland | British | 40335260002 | |||||
| SILVER, Richard Barnett | Geschäftsführer | 11755 Montana Avenue Los Angeles California Usa | Usa | 33851400001 | ||||||
| STREET, Timothy William | Geschäftsführer | Flat 23 Park House 16 Northfields SW18 1DD London | Australian | 91455710001 | ||||||
| TYLER JR, Sidney Frederick | Geschäftsführer | 969 S Madison Avenue Pasadena California 91106 Usa | Usa | 33851380001 | ||||||
| WEIGHT, James Dominic | Geschäftsführer | 11 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | England | British | 73750450005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westminster Health Care (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | The Aspect Finsbury Square EC2A 1AS London 3rd Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WESTMINSTER HEALTH CARE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Aug. 2016 Geliefert am 08. Aug. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 05. Okt. 2013 Geliefert am 10. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Dez. 2012 Geliefert am 19. Dez. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment deed | Erstellt am 27. Okt. 2006 Geliefert am 08. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company as junior creditor has undertaken that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities: in each case the junior creditor concerned shall hold the same upon trust for the security trustee and will promptly pay the same to the security trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Opco debenture accession deed | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 04. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An intercreditor and subordination agreement | Erstellt am 13. Juli 2006 Geliefert am 25. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 06. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 03. Juli 2000 Geliefert am 06. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property knowb as lower ground, ground and first floors keats house st thomas street new city court | |
Kurze Angaben The deposit of £41,250 and value added tax thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 1993 Geliefert am 18. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement dated 19TH february 1993 and this charge | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0