CHEMWASTE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CHEMWASTE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01581771 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHEMWASTE LIMITED?
- Behandlung und Beseitigung von gefährlichen Abfällen (38220) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
Wo befindet sich CHEMWASTE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Pkf Gm 3rd Floor, One Park Row LS1 5HN Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEMWASTE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHEMWASTE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Acumen House Headlands Lane Knottingley West Yorkshire WF11 0LA England zum C/O Pkf Gm 3rd Floor, One Park Row Leeds LS1 5HN am 19. Okt. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Damien Murray als Geschäftsführer am 28. Juni 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Grahame Henderson als Direktor am 30. Dez. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Ashall als Geschäftsführer am 25. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2023 bis 30. Dez. 2022 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 10 Seiten | MA | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Mr Michael Ashall zum Geschäftsführer | 3 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Damien Murray als Direktor am 21. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Leon Kirk als Geschäftsführer am 21. Juni 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Ashall als Direktor am 21. Juni 2022 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Brian Mccabe als Direktor am 21. Juni 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHEMWASTE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSSLEY, Andrew Peter | Geschäftsführer | 3rd Floor, One Park Row LS1 5HN Leeds C/O Pkf Gm | England | British | Director | 187481940001 | ||||
HENDERSON, Grahame | Geschäftsführer | 3rd Floor, One Park Row LS1 5HN Leeds C/O Pkf Gm | England | English | Accountant | 188245570001 | ||||
MCCABE, Brian | Geschäftsführer | Ballymount Road Upper D24 E097 Dublin 24 Panda Waste Management Solutions Ireland | Ireland | Irish | Ceo | 159390940001 | ||||
SUTTON, Kristian David | Geschäftsführer | 3rd Floor, One Park Row LS1 5HN Leeds C/O Pkf Gm | England | British | Director | 169405780001 | ||||
BROWN, Mavis | Sekretär | 72 Whitcliffe Road BD19 3BY Cleckheaton West Yorkshire | British | 27561530001 | ||||||
THOMSON, Carol | Sekretär | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | British | 168468340001 | ||||||
ASHALL, Michael | Geschäftsführer | Argyle Street CH41 6AF Birkenhead 68 Merseyside England | England | British | Director | 149880560001 | ||||
BROWN, Andrew James | Geschäftsführer | 19 Sunny Bank Avenue WF14 0NF Mirfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Waste Management | 99051370002 | ||||
BROWN, David Michael | Geschäftsführer | 12 Ebor Gardens WF13 3BH Mirfield West Yorkshire | British | Waste Management | 99051180003 | |||||
BROWN, James | Geschäftsführer | 72 Whitcliffe Road BD19 3BY Cleckheaton West Yorkshire | England | British | Chemical Waste Engineer | 27561540001 | ||||
BROWN, Mavis | Geschäftsführer | 72 Whitcliffe Road BD19 3BY Cleckheaton West Yorkshire | England | British | Secretary | 27561530001 | ||||
BROWN, William John | Geschäftsführer | 97 West End Drive BD19 6YD Cleckheaton West Yorkshire | British | Waste Management | 99051270002 | |||||
KIRK, Leon | Geschäftsführer | Headlands Lane WF11 0LA Knottingley Acumen House West Yorkshire England | England | British | Director | 161419120001 | ||||
LAPPIN, Michelle | Geschäftsführer | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | Scotland | British | Director | 87722880002 | ||||
MURRAY, Damien | Geschäftsführer | Ballymount Road Upper D24 E097 Dublin 24 Panda Waste Management Solutions Ireland | Ireland | Irish | Waste Management Company Director | 294774960001 | ||||
TOWERS, Simon | Geschäftsführer | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | Scotland | British | Director | 98699910001 | ||||
WALKER, Stewart | Geschäftsführer | Cemetery Lane Preesall FY6 0PH Poulton-Le-Fylde Park Cottage Farm England | England | British | Director | 254125200001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHEMWASTE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acumen Waste Services Limited | 13. Nov. 2020 | Headlands Lane WF11 0LA Knottingley Acumen House West Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Bradley Park Waste Management Limited | 31. März 2020 | St. Peters Square M2 3DE Manchester 1 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Robert Mcfarlane | 01. Apr. 2017 | St. Vincent Street First Floor G2 5QD Glasgow 183 Scotland | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Simon Towers | 01. Apr. 2017 | South Road Bowdon WA14 2JZ Altrincham 11 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Scotland | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CHEMWASTE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 04. Apr. 2012 Geliefert am 13. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Apr. 2012 Geliefert am 13. Apr. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Leasehold land at low mill lane ravensthorpe industrial estate dewsbury with title number wyk 211491 leasehold land on the east side of low mill lane ravensthorpe industrial estate dewsbury and leasehold land known as unit 1 low mill lane ravensthorpe industrial estate dewsbury with title number wyk 909640 all fixtures & fittings & all fixed plant & machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sales acts). A floating charge over all unfixed plant & machinery & other chattels & equipment, & assigns the goodwill of the business carried on at or from the property & the benefit of the licence or certificate. The right to recover & receive any compensation payable in respect of the licence or the certificate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. März 1994 Geliefert am 15. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings lying to the south east of huddersfield road ravensthorpe dewsbury t/n WYK211491 and all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. März 1994 Geliefert am 14. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat CHEMWASTE LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0