LEADING TECHNOLOGY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LEADING TECHNOLOGY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01584188 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PROTEK TECHNOLOGY LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
BRIARBELL LIMITED | 04. Sept. 1981 | 04. Sept. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cody Technology Park Ively Road Farnborough Hampshire GU14 0LX zum C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ am 23. Nov. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Stephen Field am 17. Apr. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Richard Willis als Geschäftsführer am 21. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Alexander Haworth als Geschäftsführer am 13. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von James Stephen Field als Sekretär am 25. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Heather Anne Cashin als Direktor am 25. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von James Stephen Field als Direktor am 25. Aug. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Messent als Sekretär am 11. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Boldon James Holdings Limited as a person with significant control on 22. Juni 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Leslie Sugden als Geschäftsführer am 22. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD, James Stephen | Sekretär | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard | 299524900001 | |||||||
CASHIN, Heather Anne | Geschäftsführer | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard | England | British | Accountant | 298988210001 | ||||
FIELD, James Stephen | Geschäftsführer | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard | England | British | Solicitor | 298479420002 | ||||
BERMAN, John Michael | Sekretär | 19 Moreton Place SW1V 2NL London | British | 13050490001 | ||||||
BOARDMAN, Lynton David | Sekretär | Cherwell Forest Drive KT20 6LU Kingswood Surrey | British | 72633900005 | ||||||
FRENCH, Rodger Ernest Arthur | Sekretär | 1 Northumberland Avenue HP21 7HG Aylesbury Buckinghamshire | British | 23883290001 | ||||||
HACKETT, Katherine Ann | Sekretär | The Hawthorns Harbour Lane, Wheelton PR6 8JS Chorley Lancashire | British | Finance Director | 105793600003 | |||||
MESSENT, Jon | Sekretär | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | British | 157181650001 | ||||||
PERKS, Timothy Howard | Sekretär | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | British | Company Secretary | 100207880001 | |||||
SUGDEN, Martin Leslie | Sekretär | Hill House Heckfield RG27 0JY Hook Hampshire | British | Company Director | 63057200002 | |||||
ADCOCK, Miles John, Dr | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | Managing Director | 177091950001 | ||||
BEAUMONT, Paul Anthony | Geschäftsführer | Church Croft Church Lane HX5 9QB Elland West Yorkshire | England | British | Ceo | 89531160001 | ||||
BENNETT, Simon David, Dr | Geschäftsführer | Manor Farm House Main Street, Westbury NN13 5JR Brackley Northamptonshire | United Kingdom | British | New Venture Director | 74322240001 | ||||
BERMAN, John Michael | Geschäftsführer | 19 Moreton Place SW1V 2NL London | British | Chairman | 13050490001 | |||||
BUTCHER, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | Fosse Way Harbury CV33 9JP Nr Leamington Spa Leamington Hall Farm Warwickshire | England | British | Managing Director | 134288870001 | ||||
CORDING, Stephen | Geschäftsführer | 114 Norsey Road CM11 1BH Billericay Essex | England | British | Finance Director | 92462850001 | ||||
EVANS, Geoffrey Christopher | Geschäftsführer | The Cottage Harpsden RG9 4HL Henley-On-Thames Oxon | British | Managing Director | 32812800001 | |||||
EVANS, Spencer Gareth | Geschäftsführer | Buckingham Gate SW1E 6PD London 85 | England | British | Finance Director | 148976480001 | ||||
GARROD, Kim Maria Michelle | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | Finance Director | 130666660002 | ||||
GARROD, Michael James Baring | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | Programme Director | 224052010001 | ||||
HAWORTH, John Alexander | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | Finance Director | 246944280001 | ||||
HUMPHRIES, Nicholas James | Geschäftsführer | 8 Maple Fold New Farnley LS12 5RX Leeds West Yorkshire | British | Venture Capitalist | 45629590001 | |||||
LING, Christopher Adam | Geschäftsführer | 85 Buckingham Gate London SW1E 6PD | England | British | Financial Controller | 65865520001 | ||||
MACFARLANE, Andrew John | Geschäftsführer | Gatehouse Ranters Lane TN17 1HL Kilndown Kent | England | British | Company Director | 13050510001 | ||||
MCNAUGHT-DAVIS, James | Geschäftsführer | 28 King Street SW1 London | Irish | Financier | 65403370002 | |||||
PALETHORPE, Mark John | Geschäftsführer | 2 Fitzwilliams Court Greatford PE9 4QQ Stamford Lincolnshire | British | Finance Director | 125949860001 | |||||
PALSER, Adam Howard, Dr | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire England | United Kingdom | British | Managing Director | 248968590001 | ||||
PICON, Jaime | Geschäftsführer | Apartado 60649 Caracas 10 FOREIGN Venezuela | Venezuelan | Company Director | 46984050001 | |||||
RAZDAN, Sanjay | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | Canadian | Managing Director | 165471790001 | ||||
SMITHAM, Peter | Geschäftsführer | 51 Yeomans Row SW3 2AL London | British | Investment Advisor | 73234100001 | |||||
SUGDEN, Martin Leslie | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 63057200004 | ||||
WATTERSON, Ian George Walter | Geschäftsführer | 314 Barkham Road RG41 4DA Wokingham Berkshire | British | Chartered Accountant | 81496480001 | |||||
WILLIS, James Richard | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | Company Director | 243854880001 | ||||
WOOD, Martin James | Geschäftsführer | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park Hampshire | England | British | Finance Director | 45073950001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LEADING TECHNOLOGY LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyldan 11 Limited | 06. Apr. 2016 | Ively Road GU14 0LX Farnborough Cody Technology Park United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat LEADING TECHNOLOGY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 02. Juni 2005 Geliefert am 08. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Juli 2003 Geliefert am 11. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 1998 Geliefert am 15. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liability of the company under the guarantee and debenture together with all moneys,and liabilities which are now or at any time have become due and shall not have been paid under a loan agreement dated 31 march 1998 and made between protek network management limited (1) greyrock business credit (a division of nationscredit commercial corporation) (2) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. März 1998 Geliefert am 07. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge on book debts | Erstellt am 25. Nov. 1991 Geliefert am 26. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due or owing or incurred to the company but limited to book and other debts arriving and payable in the U.K. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 18. Jan. 1983 Geliefert am 20. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat LEADING TECHNOLOGY LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0