ENZA MOTORS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ENZA MOTORS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01587033 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENZA MOTORS LIMITED?
- Verkauf von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45111) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Verkauf von Gebrauchtwagen und leichten Nutzfahrzeugen (45112) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (45200) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Einzelhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45320) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich ENZA MOTORS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENZA MOTORS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ENSOR MOTORS LIMITED | 01. Okt. 1985 | 01. Okt. 1985 |
MIDLAND COMMERCIAL VEHICLES (STOKE) LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
SLIMFLOAT LIMITED | 22. Sept. 1981 | 22. Sept. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENZA MOTORS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENZA MOTORS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Anthony Kempson als Geschäftsführer am 08. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Roanza Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Roy Charles Reed as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Cessation of Brian Anthony Kempson as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Thomas Stead als Geschäftsführer am 30. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Peter Jones als Sekretär am 30. Juni 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Thomas Stead als Sekretär am 30. Juni 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Clifford Fox als Geschäftsführer am 25. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENZA MOTORS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Michael Peter | Sekretär | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | 200992510001 | |||||||
JONES, Michael Peter | Geschäftsführer | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | England | British | Finance Director | 140687070001 | ||||
REED, Roy Charles | Geschäftsführer | 207 Clee Road DN35 9HU Cleethorpes South Humberside | England | British | Director | 29128410001 | ||||
ARRATOON, David Gregory | Sekretär | 36 Hungerford Place CW11 4PP Sandbach Cheshire | British | 32717820001 | ||||||
BARRETT, Nigel John | Sekretär | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | British | 15118100001 | ||||||
BARRETT, Nigel John | Sekretär | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | British | Company Director | 15118100001 | |||||
SMITH, Gerry Vincent | Sekretär | The Cart Hovel Lowes Lane, Swarkestone DE73 7GQ Derby Derbyshire | British | Managing Director | 161300420001 | |||||
STEAD, John Thomas | Sekretär | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | 167999930001 | |||||||
WEBB, James Keith | Sekretär | 1 Wood Lane Sutton Weaver WA7 3EN Runcorn Cheshire | British | Company Director | 17378660001 | |||||
ARRATOON, David Gregory | Geschäftsführer | 36 Hungerford Place CW11 4PP Sandbach Cheshire | England | British | Chartered Accountant | 32717820001 | ||||
BARRETT, Nigel John | Geschäftsführer | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15118100001 | ||||
BARRETT, Nigel John | Geschäftsführer | The Cottage Park Lane Brocton ST17 0TS Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15118100001 | ||||
BROWN, Alec Charles | Geschäftsführer | 10 Newquay Court CW12 3BQ Congleton Cheshire | British | Company Director | 17378650001 | |||||
ELGAR PARSONS, Russell | Geschäftsführer | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | England | British | Sales & Marketing Director | 124265650002 | ||||
FOX, Steven Clifford | Geschäftsführer | The Hawthorn West End LN1 2XY Ingham Lincolnshire | England | British | Sales Director | 125294270001 | ||||
GOSLING, Richard Neil | Geschäftsführer | Mistal Loft Vicarage Lane CW11 4TB Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | Director | 114025020001 | ||||
KEMPSON, Brian Anthony | Geschäftsführer | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | England | British | Managing Director | 156744840002 | ||||
ROSS, John Allan | Geschäftsführer | Millbeck House Gill Lane Rawdon LS19 7DG Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 43839050001 | ||||
SADOWSKI, Francis William | Geschäftsführer | 14 Crossmoor Crescent Romiley SK6 4AG Stockport Cheshire | British | Sales Director | 34903160001 | |||||
SMITH, Gerry Vincent | Geschäftsführer | The Cart Hovel Lowes Lane, Swarkestone DE73 7GQ Derby Derbyshire | England | British | Managing Director | 161300420001 | ||||
STEAD, John Thomas | Geschäftsführer | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | United Kingdom | British | Finance Director | 65971430001 | ||||
WEBB, James Keith | Geschäftsführer | 1 Wood Lane Sutton Weaver WA7 3EN Runcorn Cheshire | British | Company Director | 17378660001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENZA MOTORS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Roy Charles Reed | 06. Apr. 2016 | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Brian Anthony Kempson | 06. Apr. 2016 | Leacroft Road Risley WA3 6NN Warrington | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Roanza Limited | 06. Apr. 2016 | Leacroft Road Birchwood WA3 6NN Warrington Enza Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ENZA MOTORS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 01. Apr. 2009 Geliefert am 04. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land south west side of bury new road manchester t/n MAN134141 all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Aug. 2006 Geliefert am 10. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land on the west side of chemical lane longbridge hayes t/n SF497409 207-217 (odd) 217A, 219 and 221 bury new road manchester and land lying to the southwest side of bury new road t/n LA70797 and MAN12010 and land and buildings at trafford park road trafford park t/n GM957042. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Juni 2001 Geliefert am 25. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 207 to 217 (odd nos) 217A, 219 and 221 bury new road manchester. T/no. LA70797 & LA64564. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. März 1999 Geliefert am 05. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Feb. 1999 Geliefert am 26. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a chemical lane longport stoke on trent staffordshire t/n-SF262436.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 23. Feb. 1999 Geliefert am 26. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Okt. 1992 Geliefert am 03. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land and buildings on th west side of chemical lane,longbridge hayes,newcastle under lyme. Staffordshire t/n sf 262436. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 06. Dez. 1991 Geliefert am 11. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company;and all patents patent applications inventions trade marks trade namesregistered designs copyrights.(see form 95 document M606 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Juni 1991 Geliefert am 12. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 10. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 21. Dez. 1987 Geliefert am 24. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 27. Jan. 1982 Geliefert am 01. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0