SILENTDALE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSILENTDALE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01587913
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SILENTDALE LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich SILENTDALE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SILENTDALE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für SILENTDALE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Aug. 2020

    9 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Alyson Elizabeth Mulholland als Sekretär am 08. Sept. 2020

    1 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Aug. 2019

    9 SeitenLIQ03

    Änderung der Details des Sekretärs für Alyson Elizabeth Mulholland am 04. März 2019

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Robert Turner am 04. Jan. 2019

    2 SeitenCH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Gresham Street London EC2V 7HN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 18. Sept. 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Aug. 2018

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Juni 2017 bis 28. Juni 2017

    1 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von SILENTDALE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Geschäftsführer
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    EnglandBritish152332230001
    FOX, Gerard Ashley
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    TURNER, John Robert
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish76185650001
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    JOHNSON, Michelle Antoinette Angela
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    Sekretär
    Floor East
    Tower House Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st
    England
    England
    179045700001
    MULHOLLAND, Alyson Elizabeth
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    Sekretär
    Chester Business Park
    CH4 9FB Chester
    Cawley House
    United Kingdom
    241424550001
    SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs.
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Irish45487120004
    STAFFORD, Paul Andrew
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    Sekretär
    85 Roman Road
    IG1 2NZ Ilford
    Essex
    British48252270001
    HILL SAMUEL BANK LIMITED
    100 Wood Street
    EC2P 2AJ London
    Sekretär
    100 Wood Street
    EC2P 2AJ London
    3915480001
    BASING, Anthony Mark
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    British99221710001
    CHOWN, Richard Henry Iyan
    Beehive Cottage
    Little Horkesley
    CO6 4DF Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Beehive Cottage
    Little Horkesley
    CO6 4DF Colchester
    Essex
    United KingdomBritish8368960001
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    Geschäftsführer
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritish46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British32423210001
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Geschäftsführer
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British40761160001
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Geschäftsführer
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish152766650002
    GRANT, Mark Andrew
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    Geschäftsführer
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    United KingdomBritish236442470001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    Geschäftsführer
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritish141461000001
    GREIG, Paul
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish163004650001
    HARRIS, Kevin Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritish170091040001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritish8949580001
    HERBERT, Jon Mark
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Geschäftsführer
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish203539400001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JOSEPH, Michael William
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish44954410002
    JUKES, Anthony Wilfrid
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Potts Farm Chennell Park Lane
    TN30 6XA Tenterden
    Kent
    British50640090001
    KING, Roger Steuart
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    Geschäftsführer
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    United States Citizen79713690002
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    MOORE, Alan Edward
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    Geschäftsführer
    Flat 2, 20 Wigmore Street
    W1U 2RQ London
    British71480200001
    PELLY, Richard Fowler
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    Geschäftsführer
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    EnglandBritish99868440002
    PETERS, Stephen John
    Birches 85 St Georges Road West
    BR1 2NR Bickley
    Kent
    Geschäftsführer
    Birches 85 St Georges Road West
    BR1 2NR Bickley
    Kent
    British56296720001
    PRITCHARD, David Peter
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    Geschäftsführer
    17 Thorney Crescent
    SW11 3TT London
    EnglandBritish57244610001
    RIDING, Frederick Michael Peter
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    Geschäftsführer
    York House
    Clifton Down Road
    BS8 4AG Clifton
    Bristol
    British76317830002
    ROGERS, Malcolm Courtney
    Oaktree Cottage
    11 Ashley Green Road
    HP5 3PE Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Oaktree Cottage
    11 Ashley Green Road
    HP5 3PE Chesham
    Buckinghamshire
    British38366410001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SILENTDALE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer02468722
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SILENTDALE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Trust indenture and security agreement (combi 2)
    Erstellt am 26. Okt. 2004
    Geliefert am 03. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the freight partnership LLP ("the head lessor) to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estate right, title and interest in to and under the following described property, rights, interest and privileges other than the excepted property but otherwise including all property specifically subjected to the lien. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank Northwest, National Association (Indenture Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement (combi 2)
    Erstellt am 26. Okt. 2004
    Geliefert am 03. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and the grand leasing partnership LLP (the "head lessor") to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estate right, title and interest in to and under the following described property, rights, interest and privileges other than the excepted property but otherwise including all property specifically subjected to the lien. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank Northwest, National Association (Indenture Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement (combi 2)
    Erstellt am 26. Okt. 2004
    Geliefert am 03. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and the clearwater partnership LLP (the "head lessor") to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estate right, title and interest in to and under the following described property, rights, interest and privileges other than the excepted property but otherwise including all property specifically subjected to the lien. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank Northwest, National Association (Indenture Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement (combi 2)
    Erstellt am 26. Okt. 2004
    Geliefert am 03. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and the emerson partnership LLP(the "head lessor") to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estate right, title and interest in to and under the following described property, rights, interest and privileges other than the excepted property but otherwise including all property specifically subjected to the lien. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wells Fargo Bank Northwest, National Association (Indenture Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement supplement no.1
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 31. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from last train limited (the borrower), silentdale, the clarkesville leasing partnership,LLP 9THE partnership) and rail wagon leasing limited (the general partner) to hsh nordbank ag under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The units and all replacements thereof and substitutions thereof. The borrowers partnership interest in the partnership. The granting clause documents. All rents issues profits revenues and other income of the property subjected or requires to be subjected to the lien of the trust indenture. All requisition proceeds with respect of the units or any part thereof, and all insurance policies and proceeds with respect to the units or any part thereof. All moneys and securities paid or deposited or required to be paid or deposited into the collateral account, all proceeds of the foregoing but excluding all excepted property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsh Nordbank Ag (The Indenture Trustee)
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement
    Erstellt am 30. Sept. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from last train limited ("the borrower"), the clarkesville leasing partnership, LLP (the "lessor"), rail wagon leasing limited (the "general partner") and the lessees (as defined in the trust indenture) to the chargee and the lenders and all monies due or to become due from lloyds investment to lloyds tsb bank PLC under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of assignment the units, the borrower's partnership interest in the lessor, the granting clause documents, all requisition proceeds in relation to the units, all moneys and securities paid or deposited and all the proceeds of the foregoing but excluding excepted property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Landesbank Schleswig - Holstein Girozentrale (The "Indenture Trustee")
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement
    Erstellt am 09. Mai 2002
    Geliefert am 21. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from blues limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of assignment the units, the borrower's partnership interest in the lessor, the granting clause documents, all requisition proceeds in relation to the units, all moneys and securities paid or deposited and all the proceeds of the foregoing but excluding excepted property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 07. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due or to become due from funk limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estate right title and interest of the borrower and the lessor in and to and under the following described property rights interests and privileges other than the excepted property please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC (The "Indenture Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement
    Erstellt am 10. Okt. 2001
    Geliefert am 25. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The prompt payment of the principal of and interest on and all other amounts due with respect to the loan by the royal bank of scotland PLC, new york branch from time to time outstanding hereunder and all other amounts outstanding hereunder by creedence limited (the borrower) (including without limitation breakage loss and increased costs). The performance and observance by the borrower for the benefit of the royal bank of scotland PLC new york branch of all the agreements covenants and provisions contained in the trust indenture, in the participation agreement and/or the other operative documents. The prompt payment of all amounts from time to time owing under the participation agreement and the other operative documents by the lessor, revival leasing limited (the general partner) and the lessees in each case to the chargee and the lenders. The performance and observance by the lessor, the general partner and the lessees of all the agreements covenants and provisions of the operative documents for the benefit of the lenders and the prompt payment of the principal of, premium (if any) and interest on and all other amounts due with respect to the loan by lloyds tsb bank PLC from time to time outstanding hereunder and all other amounts owing by lloyds investment under the junior loan agreement (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The units (as defined) and all related parts (as defined) and all replacements thereof and substitutions therefor in which the lessor shall from time to time acquire an interest as provided in each lease... See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC (The "Indenture Trustee")
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Trust indenture and security agreement
    Erstellt am 29. Mai 2001
    Geliefert am 12. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The prompt payment of the principal of and interest on and all other amounts due with respect to the loan by the royal bank of scotland PLC, new york branch from time to time outstanding hereunder and all other amounts outstanding hereunder by crosby limited (the borrower) (including without limitation breakage loss (as defined) and increased costs (as defined). The performance and observance by the borrower for the benefit of the royal bank of scotland PLC new york branch of all the agreements covenants and provisions contained in the trust indenture, in the participation agreement (as defined) and/or the other operative documents (as defined). The prompt payment of all amounts from time to time owing under the participation agreement and the other operative documents by the lessor, stills limited (the general partner) and the lessees (as defined) in each case to the chargee and the lenders. The performance and observance by the lessor, the general partner and the lessees of all the agreements covenants and provisions of the operative documents for the benefit of the lenders and the prompt payment of the principal of, premium (if any) and interest on and all other amounts due with respect to the loan by lloyds tsb bank PLC from time to time outstanding hereunder and all other amounts owing by lloyds investment under the junior loan agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    The units (as defined) and all related parts (as defined) and all replacements thereof and substitutions therefor in which the lessor shall from time to time acquire an interest as provided in each lease. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SILENTDALE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Aug. 2018Beginn der Liquidation
    07. Sept. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0