A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED

A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameA C L AIRCRAFT TRADING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01588506
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    • Luftfrachtverkehr (51210) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Thorntonrones Limited
    311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    A C L AVIATION TRADING LIMITED16. Juni 200816. Juni 2008
    B A C GROUP LIMITED30. Juni 198930. Juni 1989
    BUSINESS AIR CENTRE LIMITED30. Sept. 198130. Sept. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13
    YBZPORY1

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Nov. 2022

    10 SeitenLIQ03
    YBJESBWJ

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Nov. 2021

    11 SeitenLIQ03
    YAK0WWV4

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Nov. 2020

    16 SeitenLIQ03
    A9ZSVTBN

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 7 Savoy Court London WC2R 0EX England zum Thorntonrones Limited 311 High Road Loughton Essex IG10 1AH am 20. Nov. 2019

    2 SeitenAD01
    A8I8LH8X

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01
    A8I8LH8P

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    A8I8LH95

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Nov. 2019

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X8BPEMNF

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Hanover House 14 Hanover Square London W1S 1HP United Kingdom zum 7 Savoy Court London WC2R 0EX am 05. Aug. 2019

    1 SeitenAD01
    X8B71OWB

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04
    X81MQDNV

    Erfüllung der Belastung 015885060046 vollständig

    1 SeitenMR04
    X81MQE3D

    Ernennung von Ms Mary Townsend als Sekretär am 11. Dez. 2018

    2 SeitenAP03
    X7KNOGC3

    Beendigung der Bestellung von Mark O'kelly als Sekretär am 11. Dez. 2018

    1 SeitenTM02
    X7KNOFQO

    Beendigung der Bestellung von Niall O'connor als Sekretär am 08. Nov. 2018

    1 SeitenTM02
    X7KKY92O

    Ernennung von Mr Mark O'kelly als Sekretär am 08. Nov. 2018

    2 SeitenAP03
    X7KKY4PM

    Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2017

    12 SeitenAA
    X7H5S7U0

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X7BVK4LK

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 25. Dez. 2016

    2 SeitenAA
    X6ED7MXO

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lancaster Business Park Aviation Way Southend on Sea Essex SS2 6UN zum Hanover House 14 Hanover Square London W1S 1HP am 29. Aug. 2017

    1 SeitenAD01
    X6DU7JDM

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X6CX5CFE

    Change of details for Asl Aviation Group Limited as a person with significant control on 14. März 2017

    2 SeitenPSC05
    X6CX4ZWA

    Eintragung der Belastung 015885060046, erstellt am 06. Sept. 2016

    46 SeitenMR01
    X5FVDYXT

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    18 SeitenAA
    A5F4HBCJ

    Wer sind die Geschäftsführer von A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TOWNSEND, Mary
    311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Thorntonrones Limited
    Essex
    Sekretär
    311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Thorntonrones Limited
    Essex
    253383600001
    ANDREW, David William
    Libra Avenue
    Morehill Close
    Benoni 1501
    20
    South Africa
    Geschäftsführer
    Libra Avenue
    Morehill Close
    Benoni 1501
    20
    South Africa
    South AfricaSouth AfricanMarketing Director141129840004
    FLYNN, Hugh Reginald Alexander
    311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Thorntonrones Limited
    Essex
    Geschäftsführer
    311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Thorntonrones Limited
    Essex
    IrelandIrishDirector107742870004
    O'CONNOR, Niall
    Malahide Road
    Swords
    Co Dublin
    3
    Dublin
    Ireland
    Sekretär
    Malahide Road
    Swords
    Co Dublin
    3
    Dublin
    Ireland
    169637950001
    O'KELLY, Mark
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Hanover House
    United Kingdom
    Sekretär
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Hanover House
    United Kingdom
    253333520001
    PASQUILL, Graham
    Orchard Oast Park Farm
    Queen Street
    TN26 6NS Paddock Wood
    Kent
    Sekretär
    Orchard Oast Park Farm
    Queen Street
    TN26 6NS Paddock Wood
    Kent
    British70181600001
    PHILLIPS, James Edward Franklyn
    7 Broomfield Road
    BR3 3QB Beckenham
    Kent
    Sekretär
    7 Broomfield Road
    BR3 3QB Beckenham
    Kent
    British23736360002
    BOETTGER, Roeloff Jacobus
    3a Macfarlane Road
    Bedfordview
    FOREIGN Johannesburg
    South Africa
    Geschäftsführer
    3a Macfarlane Road
    Bedfordview
    FOREIGN Johannesburg
    South Africa
    South AfricanDirector111390000001
    DICKSON, Neil Alan
    The White House
    Chatter Alley
    RG27 8SS Dogmersfield
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The White House
    Chatter Alley
    RG27 8SS Dogmersfield
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director8825460001
    INGARFIELD, Ronald William John
    Irony Too Park View Road
    Woldingham
    CR3 7DH Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Irony Too Park View Road
    Woldingham
    CR3 7DH Caterham
    Surrey
    EnglandBritishDirector7255070001
    KELLAR, Rudy Shawn
    2a Greys Lane
    IRISH Howth
    Dublin 13
    Ireland
    Geschäftsführer
    2a Greys Lane
    IRISH Howth
    Dublin 13
    Ireland
    CanadianDirector96958260001
    MACK, Alastair Graham
    Bracken House
    Crooksbury Road
    GU10 1RF Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bracken House
    Crooksbury Road
    GU10 1RF Farnham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director111604170001
    MACK, Harvey Graham
    Little Bridley Berry Lane
    Worplesdon
    GU3 3QF Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Bridley Berry Lane
    Worplesdon
    GU3 3QF Guildford
    Surrey
    BritishCompany Director9837730001
    PASQUILL, Graham
    Orchard Oast Park Farm
    Queen Street
    TN26 6NS Paddock Wood
    Kent
    Geschäftsführer
    Orchard Oast Park Farm
    Queen Street
    TN26 6NS Paddock Wood
    Kent
    BritishCompany Director70181600001
    RUTHERFORD, John David
    20 Muirfield Park
    HU5 3JF Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    20 Muirfield Park
    HU5 3JF Hull
    North Humberside
    BritishCompany Executive15026700001
    SCOTT, Peter Allan
    The Willows
    Balheary
    IRISH Swords
    Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    The Willows
    Balheary
    IRISH Swords
    Dublin
    Ireland
    IrelandSouth AfricanAccountant89599350001
    STURMAN, Robert
    Rangers
    Pembley Green
    RH10 3LF Copthorne
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Rangers
    Pembley Green
    RH10 3LF Copthorne
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector74309050001
    WEBB, David Merrick
    Peggy Farrow House Dale Road
    Elloughton Dale
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Peggy Farrow House Dale Road
    Elloughton Dale
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    AustralianCompany Executive33951300001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Asl Aviation Holdings Dac
    Malahide Road
    Swords
    3
    Co Dublin
    Ireland
    06. Apr. 2016
    Malahide Road
    Swords
    3
    Co Dublin
    Ireland
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandIreland
    RechtsgrundlageIrish Companies Act 2016
    RegistrierungsortCompanies Registration Office, Ireland
    Registrierungsnummer361394
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

    Hat A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 06. Sept. 2016
    Geliefert am 19. Sept. 2016
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 20. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed to a master aircraft mortgage dated 6 february 2001
    Erstellt am 08. Okt. 2004
    Geliefert am 19. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 shorts SD360-200 aircraft s/no SH3661 reg no g-exps, the engines and technical records.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of memorandum of varation
    Erstellt am 17. Sept. 2004
    Geliefert am 18. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-xpss: serial number sh.3713, It is hereby agreed: page 22, (schedule 1) of the mortgage agreement delete after engine serial number pce 97384 and insert PCE97103 page 12, (schedule 1) of the loan agreement delete after serial number pce 97384AND inset pce 97103.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of memorandum of varation
    Erstellt am 09. Juni 2004
    Geliefert am 11. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-oblk: serial number sh.3712, It is hereby agreed: page 22, (schedule 1) of the mortgage agreement delete after serial number pce 97103, and page 12, (schedule 1) of the loan agreement delete after serial number pce 97103.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 11. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The aircraft mortgage
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-xpss: serial number sh.3713 Including the engines and all equipment all replacement renewals and additions made thereto, the insurances, requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The aircraft mortgage
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-boeg: serial number sh.3733 Including the engines and all equipment all replacement renewals and additions made thereto, the insurances, requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The aircraft mortgage
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-oblk: serial number sh.3712 Including the engines and all equipment all replacement renewals and additions made thereto, the insurances, requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The aircraft mortgage
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-clas: serial number sh.3635 Including the engines and all equipment all replacement renewals and additions made thereto, the insurances, requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The aircraft mortgage
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    SD3-60 variant 100: registration mark g-bnmu: serial number sh.3724 Including the engines and all equipment all replacement renewals and additions made thereto, the insurances, requisition compensation.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 13. Feb. 2004
    Geliefert am 26. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The aircraft, the insurances and the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental deed to a master lease assignment dated 6 february 2001,
    Erstellt am 05. Feb. 2004
    Geliefert am 12. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any assignor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The relevant assigned property being all rights under the lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental deed to a master aircraft mortgage dated 6 february 2001,
    Erstellt am 05. Feb. 2004
    Geliefert am 12. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any mortgagor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    One fokker F27 aircraft s/no 10627 UK reg mark g-jead including the engines and the technical records subject to the terms of the master aircraft mortgage.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of memorandum of variation
    Erstellt am 19. Jan. 2004
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fokker F27 mark 500 : registration mark g-jead : serial number 10627 whereas by an aircraft mortgage dated 31ST march 2000 and a loan agreement dated 31ST march 2000 it is hereby agreed page 23 (schedule 1) of the mortgage agreement and delete after engine serial number 14596 and insert 19055 page 12 (schedule 1) of the loan agreement delete after engine serial number 14596 and insert 19055. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of memorandum of variation
    Erstellt am 19. Jan. 2004
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being fokker F27 mark 500: registration mark g-bvob : serial number 10366 whereas by an aircraft mortgage dated 19TH november 1997 and a loan agreement dated 25TH may 2000 it is hereby agreed page 19 (schedule 1) of the mortgage agreement delete after engine serial number 19055 and insert 14596 page 12 (schedule 1) of the loan agreement delete after engine serial number 19055 and insert 14596. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to a master aircraft mortgage dated 6 february 2001
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 18. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any mortgagor to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The aircraft including the engines and technical records.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The supplemental deed to a master aircraft mortgage dated 6 february 2001 and
    Erstellt am 11. Juni 2003
    Geliefert am 19. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any mortgagor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first priority legal mortgage the aircraft including the engines. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of variation
    Erstellt am 10. Apr. 2002
    Geliefert am 11. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fokker F27 mark 500: registration mark g-bvob: serial number 10366. (1) whereas by an aircraft mortgage dated 19 november 1997 and a loan agreement dated 25 may 2000, the company agreed to provide a loan to the owner secured by a mortgage over the aircraft g-bvob, (2) the company and the owner now wish to amend certain of the provisions in the mortgage and loan agreement. (3) this agreement is supplemental to the mortgage and loan agreement. It is hereby agreed page 19, (schedule 1) of the mortgage agreement: delete engine serial number 13207, page 12, (schedule 1) of the loan agreement: delete engine serial number 13207.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited as Agent and Security Trustee
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 30. Nov. 2001
    Geliefert am 07. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of foreign currency risk with respect to various loans
    Kurze Angaben
    The deposit and all right title benefit and interest of the company whatsoever present and future therein together with any certificates of deposit deposit receipts or other instruments or securities relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited (As Agent and Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 06. Juli 2001
    Geliefert am 14. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement between the company and the chargee dated 15TH january 1999 the charges over the aircraft known as SD360-200 serial number SH3713 dated 1ST february 1999 abd registered at companies house on 18TH february 1999 or the security assignment
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to any sums payable to on on account of the company pursuant to the lease agreement dated 30TH april 2001 and all other rights and benefits whatever in respect of the aircraft accruing to the company.
    Berechtigte Personen
    • Daimlerchrysler Capital Services (Debis) UK Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master aircraft mortgage
    Erstellt am 28. März 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the transaction documents
    Kurze Angaben
    The aircraft, the insurances and the requisition compensation and the whole benefit of its right title and interest in any warranties in respect of the aircraft (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed incorporating the terms and conditions of the master aircraft mortgage dated 28/03/01
    Erstellt am 28. März 2001
    Geliefert am 04. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the transaction documents
    Kurze Angaben
    The aircraft, the insurances and the requisition compensation and the whole benefit of its right title and interest in any warranties in respect of the aircraft (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master aircraft mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 2001
    Geliefert am 26. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all monies liabilities and obligations (whether actual or contingent) due or to become due from or by any mortgagor to the chargee under or pursuant to the mortgage or under or in connection with any of the operative documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The aircraft shorts sd 360-300 aircraft M.S.n sh-3758 UK registration mark g-kbac with two pratt & whitney PT6A-67R engines with M.S.ns pce 106112 and pce 106107 shorts SD360-100 aircraft M.S.n sh-3608 UK registration mark g-bkmx with two pratt & whitney PT6A-65R engines with M.S.ns pce 97103 and pce 97148 and fokker F27-500 aircraft M.S.n 10637 UK registration mark g-jeaf with two rolls royce dart 532-7 engines with msn 18060 and 147 65. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Master lease assignment
    Erstellt am 06. Feb. 2001
    Geliefert am 26. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all monies liabilities and obligations (whether actual or contingent) due or to become due from or by any assignor to the chargee under or pursuant to any of the operative documents (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    Bac with full title guarantee assigned and agreed to assign absolutely the relevant assigned property as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Aircraft mortgage deed
    Erstellt am 24. Nov. 2000
    Geliefert am 30. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £396,000 together with all sums due or to become due by way of principal or interest
    Kurze Angaben
    First fixed aircraft mortgage over aircraft type shorts 360-200 registration mark - g-oblk serial number SH3712 together with an assignment of the rights title and interest in the insurances including all claims and the return of any premiums.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of variation
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 24. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement
    Kurze Angaben
    Fokker F27 mark 500:reg g-bvob: ser/no 10366. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat A C L AIRCRAFT TRADING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Juni 2023Soll aufgelöst werden am
    05. Nov. 2019Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Jeffery Rones
    Thornton Rones Limited 311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Essex
    Praktiker
    Thornton Rones Limited 311 High Road
    IG10 1AH Loughton
    Essex

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0