TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED

TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01588900
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
    • Künstlerische Tätigkeit (90030) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Pancras Square
    N1C 4AG London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SANCTUARY ARTIST MANAGEMENT LIMITED05. März 200205. März 2002
    SANCTUARY MUSIC MANAGEMENT LIMITED18. Nov. 199418. Nov. 1994
    SANCTUARY MUSIC (OVERSEAS) LIMITED26. Jan. 198226. Jan. 1982
    SPECFORD LIMITED02. Okt. 198102. Okt. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Boyd Johnston Muir als Geschäftsführer am 02. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    17 SeitenAA

    legacy

    126 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 4 Pancras Square London N1C 4AG verlegt

    1 SeitenAD04

    Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Abolanle Abioye am 23. Juli 2018

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Boyd Johnston Muir am 23. Juli 2018

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 364-366 Kensington High Street London W14 8NS zum 4 Pancras Square London N1C 4AG am 23. Juli 2018

    1 SeitenAD01

    Change of details for Universal Srg Group Limited as a person with significant control on 23. Juli 2018

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Juni 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    17 SeitenAA

    legacy

    136 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Beendigung der Bestellung von Richard Michael Constant als Geschäftsführer am 28. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    8 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    Ernennung von Mr Paramjit Jassal als Direktor am 18. Mai 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Brown als Geschäftsführer am 31. März 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ABIOYE, Abolanle
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Sekretär
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    BritishSecretary88802330001
    CARMEL, Simon Lloyd
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor172950720001
    JASSAL, Paramjit
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer - Finance Operations16770570003
    HOWE, Mark John
    74 Freeman Road
    OX11 7DB Didcot
    Oxfordshire
    Sekretär
    74 Freeman Road
    OX11 7DB Didcot
    Oxfordshire
    British59964200001
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    MILLER, Michael David
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    British44250870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Sekretär
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    CITY GROUP PLC
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    Sekretär
    25 City Road
    EC1Y 1BQ London
    35794270001
    ARLON, Deke
    7 Victoria Grove
    W8 5RW London
    Geschäftsführer
    7 Victoria Grove
    W8 5RW London
    BritishDirector50584250001
    ASHURST, William Anthony
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    United KingdomBritishLawyer123516100001
    BARTLETT, Andrea
    79 Cardross Street
    W6 0DP London
    Geschäftsführer
    79 Cardross Street
    W6 0DP London
    BritishSolicitor50943970002
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritishInternational Chief Financial Officer163199590001
    CASS, Michael Trevor
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    BritishChartered Accountant2320620002
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Counsel43836310003
    HAXBY, Martin James, Mr.
    Wildhern 133 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wildhern 133 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director6001160002
    MERCURIADIS, Merck
    45-53 Sinclair Road
    W14 0NS London
    Geschäftsführer
    45-53 Sinclair Road
    W14 0NS London
    CanadianMusic Manager59921890004
    MUIR, Boyd Johnston
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United StatesBritishEvo & Cfo172824510001
    NAJEEB, Aky
    Darbys
    Church Road Cookham
    SL6 9PR Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Darbys
    Church Road Cookham
    SL6 9PR Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector10689380008
    SMALLWOOD, Roderick Charles
    Courtenay Beach
    Courtenay Terrace
    BN3 2WF Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Courtenay Beach
    Courtenay Terrace
    BN3 2WF Hove
    East Sussex
    United KingdomBritishManager43907530003
    TAYLOR, Andrew John
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant54448520001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant76655520001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    15. Nov. 2016
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer00284340
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04316670
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat TWENTY-FIRST ARTISTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juni 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed")
    Erstellt am 11. Aug. 2000
    Geliefert am 30. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998
    Erstellt am 01. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Okt. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 1998
    Geliefert am 06. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture originally dated 3RD september 1997
    Erstellt am 03. Juli 1998
    Geliefert am 21. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sanctuary enterprises PLC (borrower) to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 21. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 3 september 1997
    Erstellt am 20. Mai 1998
    Geliefert am 06. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies which are as at 20 may 1998 due or to become due from sanctuary enterprises PLC (the "borrower") to the chargee under the mezzanine loan agreement dated 3 september 1997 whether pursuant to the guarantee as therein defined) or otherwise and all other sums payable pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 06. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Sept. 1997
    Geliefert am 19. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the sanctuary group PLC to the cahrgee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 13. Dez. 1991
    Geliefert am 03. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (For full details refer to doc 395 ref M115C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • A. J. Taylor & R. C. Smallwood
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Aug. 1989
    Geliefert am 23. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 31. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Dez. 1988
    Geliefert am 15. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Zomba Corporation.
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 16. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1988
    Geliefert am 18. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of guarantee dated 31.3.88 or the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Zomba Corporation of Alpenstrase
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 31. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 11. Feb. 1987
    Geliefert am 26. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from platinum travel international and/or great southern company (UK) limited and/or smallwood taylor publishing limited and/or fair warning (agency) limited and/or platinum holdings inc. And/or smallwood taylor properties inc. To the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    The personal accident/sichness insurance policies issued by stafford knight & company limited the benefit of all policies (see 395.).
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 22. Aug. 1984
    Geliefert am 28. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc for fuller details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 04. Mai 1983
    Geliefert am 11. Mai 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book & other debts with a floating charge on all (please see doc M15). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1983Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0