BRENT WALKER GROUP PLC(THE)

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRENT WALKER GROUP PLC(THE)
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01591274
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRENT WALKER GROUP PLC(THE)?

    • (7415) /

    Wo befindet sich BRENT WALKER GROUP PLC(THE)?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRENT WALKER GROUP PLC(THE)?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRENT WALKER HOLDINGS PLC31. Mai 198531. Mai 1985
    BRENT WALKER HOLDINGS LIMITED20. Juni 198320. Juni 1983
    LOCKS HEATH PROPERTIES TWENTY-ONE LIMITED14. Okt. 198114. Okt. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRENT WALKER GROUP PLC(THE)?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRENT WALKER GROUP PLC(THE)?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    3 SeitenLQ02

    legacy

    3 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 14. Dez. 2008

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    1 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Geänderte Gründungsurkunde des Gläubigerausschusses

    1 Seiten3.4

    Verschiedenes

    Stat of affairs with f 3.10
    9 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    14 Seiten3.10

    legacy

    2 Seiten88(2)R

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    13 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von BRENT WALKER GROUP PLC(THE)?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Sekretär
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    BROWN, John Michael
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    Geschäftsführer
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    British889800001
    DIBBLE, Keith George
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Newcastle Avenue
    IG6 3EE Ilford
    Essex
    British82410610001
    GOSWELL, Brian Lawrence, Sir
    Pipers
    Camley Park Drive
    SL6 6QF Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pipers
    Camley Park Drive
    SL6 6QF Maidenhead
    Berkshire
    BritainBritish20200210001
    LEACH, John Leslie
    Dunelm
    Church Road
    KT10 0JP Claygate
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dunelm
    Church Road
    KT10 0JP Claygate
    Surrey
    British1411850002
    MCDONALD, Peter Stuart
    Limes Farmhouse
    Upper Lambourn
    RG17 8RG Hungerford
    Berkshire
    England
    Geschäftsführer
    Limes Farmhouse
    Upper Lambourn
    RG17 8RG Hungerford
    Berkshire
    England
    British77781180003
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Geschäftsführer
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritish53682420001
    BRIGHT, Keith, Sir
    16 Westbourne Park Villas
    W2 5EA London
    Geschäftsführer
    16 Westbourne Park Villas
    W2 5EA London
    United KingdomBritish1770160001
    CLEMENTS, Alan William
    Wildbriar
    41 Shirley Hills Road
    CR0 7HQ Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wildbriar
    41 Shirley Hills Road
    CR0 7HQ Croydon
    Surrey
    British5575140001
    KINDERSLEY DL, Robert Hugh Molesworth, The Lord
    West Green Farm
    Shipbourne
    TN11 9PU Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    West Green Farm
    Shipbourne
    TN11 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish35554730001
    QUINLAN, Timothy Edward
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    121 Thorpe Bay Gardens
    Thorpe Bay
    SS1 3NW Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritish49553030001
    SCOBIE, Kenneth Charles
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish8867190001
    WARD, Charles John Nicholas
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Bacon House Brackley Road
    Greatworth
    OX17 2DX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish78441480001

    Hat BRENT WALKER GROUP PLC(THE) Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed supplemental to three composite guarantees and debentures dated 15TH november 1990,28TH march 1991 and 27TH march 1992
    Erstellt am 17. Juni 1997
    Geliefert am 07. Juli 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies,liabilities and other obligations of whatsoever nature due,owing or incurred by the brent walker group PLC and each of it's subsidiaries (other than the company) for the time being and from time to time to the chargee as agent and trustee for itself each of the existing lenders and hambros leasing limited (the new lender)under the term facilities agreement dated 27TH march 1992 and certain related agreements and documents (the "operative agreements")
    Kurze Angaben
    Please refer to form 395 for full details of charged assets. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 07. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 03. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies liabilities and other obligations whatsoever due from the company to the chargee in respect of the composite guarantees and debentures dated 15 november 1990 and 27 march 1992 to which this deed is supplemental under the terms of the facilities agreement dated 27 march 1992
    Kurze Angaben
    The immoveable property comprised in a lease relating to royal birkdale unit 15 the courtyard straffan county kildare and all fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee for Itself and the Lenders as Defined in the Term Facility Agreement)
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of deposit
    Erstellt am 25. Nov. 1996
    Geliefert am 04. Dez. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the letters dated 25TH november 1996 as the same may be amended, extended or replaced from time to time
    Kurze Angaben
    The initial sum of £2,020,000 and all other sums (whether of principal interst or otherwise) hereafter standing to the credit of an account of the company with standard chargtered bank with account number 02 7063652 01 which is designated "the brent walker group PLC - pubmaster incentive scheme account", or to the credit of any replacement account (the "deposit") and all of the rights to and interest of the company on and to the deposit or to require the payment of the deposit.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pubmaster Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 04. Sept. 1996
    Geliefert am 24. Sept. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the original deeds (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit h eastway commercial centre eastway hackney t/no. NGL476813 and all fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 11. Mai 1995
    Geliefert am 16. Mai 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to each of the composite guarantees and debentures dated 15TH november 1990, 19TH february 1991, 28TH march 1991 and 27TH march 1992 as supplemented
    Kurze Angaben
    The immovable property comprised in the tenancy agreement dated 10TH march 1995 relating to the 5TH floor of the premises at 19 rupert street london W1V 7FS and all fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Banklenders (As Defined)as Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transaktionen
    • 16. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over deposit
    Erstellt am 06. Apr. 1995
    Geliefert am 10. Apr. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a tax indemnity dted 4/4/95 as may be amended or extended
    Kurze Angaben
    The initial sum of £115,000 and all other sums hereafter standing to the credit of an account numbered 017048 77701. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Folksham General Mutual Insurance Society as Agent for Itself and Trustee for Emenex Companies
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over deposit
    Erstellt am 23. Feb. 1995
    Geliefert am 27. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a tax indemnity dated 23RD february 1995
    Kurze Angaben
    The initial sum of £35,350 and all other sums standing to the credit of an account of the company with standard chartered bank account no. 01 7046251 01 designated the brent walker group PLC-tax deposit account no.2. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Folksam General Mutual Insurance Societyex Companies (As Defined)for Itself and as Agent and Trustee for the Emen
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed supplemental to three composite guarantees dated 15TH november 1990, 28TH march 1991 and 27TH march 1992
    Erstellt am 01. Feb. 1995
    Geliefert am 20. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the term facility agreement dated 27TH march 1992 and the "operative agreements" (as defined in agent and trustee for emenex investments B.V.)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankts B.V.Acting as Agent and Trustee for Emenex Investmen
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over deposit
    Erstellt am 01. Feb. 1995
    Geliefert am 03. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a tax indemnity dated 1ST february 1995 and this deed (as defined therein)
    Kurze Angaben
    The initial sum of £115000 and other monies standing to the credit of an account with the bank no: 10 7045646 01. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Folksam General Mutual Insiurance Society for Itself and as Agent and Trustee Forthe Emenex Companies
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 01. Feb. 1995
    Geliefert am 02. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £450,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The company's interest in the sum of £450,000.
    Berechtigte Personen
    • Burford Trocadero Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 21. Dez. 1994
    Geliefert am 10. Jan. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The indebtedness (as defined in the original deeds, as defined in the supplemental deed) of the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The benefit of the option agreement dated 21/12/94 relating to land at unit h eastway commercial centre hackney london t/no NGL476813. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankdated 27TH March 1992)Ers as Defined in the Term Facilities Agreement(For Itself and as Agent for Itself and the Lend
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 21. Dez. 1994
    Geliefert am 03. Jan. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee to pay any sum to william hill pursuant to any of clauses 7.1 (a), 7.1 (c), 7.2 (b) and 7.3 (a) of the agreement (as defined in the original deed) or to subscribe for the loan stock (as defined in the agreement) pursuant to clause 7.2(a) of the agreement and all monies due or to become due from the company to the chargee to pay any sum to william hill in respect of any payment under any of clauses 7.1 (a), 7.1 (c), 7.2 (b) and 7.3 (a) of the agreement pursuant to any clauses 26(a), 26(b) and 26(c) of the agreement, not exceeding the aggregate of the qualifying total outstanding gm judgement debt amount (as defined in the agreement)
    Kurze Angaben
    The benefit of an option agreement dated 21ST december. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. März 1994
    Geliefert am 11. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 11. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 09. Juli 1992
    Geliefert am 27. Juli 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to four composite guarantees and debentures as defined
    Kurze Angaben
    32,792 ordinary shares of 10P and all shares and stocks bonds and debentures etc.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank as Agent and Trustee for Itself and the Lenders
    Transaktionen
    • 27. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    See doc ref M723C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The William Hill Group Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the term facilities agreements dated 27TH march 1992 and supplemental to the "principal deeds (as defined in this deed)
    Kurze Angaben
    Units 1 and 2 brent crescent,london,NW10TITLE no: AGL21657.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the term facilities agreement dated 27TH march 1992 and supplemental to the " principal deeds" (as defined in this deed)
    Kurze Angaben
    Leasehold units 1 and 2 brent crescent,london,NW10 title no:AGL21657 (see doc ref M133 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 30. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or tombecome due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as defined in and supplemental to two composite guarantees and debentures dated 15TH november 1990 and 28TH march 1991
    Kurze Angaben
    Leasehold units 1 and 2 brent crescent,london NW10 title no:AGL21657.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankacting as Agent and Trustee for Itself and Each
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 27. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under tyhe terms of the composite guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank"Lenders" as Definedacting as Agent and Trustee for Itself and The
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 1998Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 115. Dez. 2009Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Supplemental deed
    Erstellt am 09. Dez. 1991
    Erworben am 18. Feb. 1993
    Geliefert am 10. März 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due
    Kurze Angaben
    The beneficial interest in £65000 of pubmaster limited £147700000 floati ng rate secured notes 2011 for full details see form 395 REFM7.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 10. März 1993Registrierung eines Erwerbs (400)
    Debenture
    Erstellt am 09. Dez. 1991
    Geliefert am 19. Dez. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from pubmaster limited to the chargee under the terms of the loan notes and loan stock as defined in the debenture
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the legal estates indicated to be held by the company in the freehold, leasehold, heritable or other land or buildings (see form 395 for details).
    Berechtigte Personen
    • Brent Walker Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Nov. 1991
    Geliefert am 29. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement dated 11TH november 1991
    Kurze Angaben
    By way of first legal mrotgager the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details ref M157.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 29. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 18. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due from the brent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 01.07.91
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 18. Juli 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 09. Apr. 1991
    Geliefert am 25. Apr. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the orignal deeds (as defined)
    Kurze Angaben
    A debt owed by brent walker investments s A. to the company 27,850,000 french francs (for more details see form 395 ref M6).
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Acting for Itself
    • Acting for Itself & as Agent & Trustee for Itself & Each of the Lenders(As Defined).
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 28. März 1991
    Geliefert am 17. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due form the brenk walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of a facility agreement dated 28/3/91 and this deed
    Kurze Angaben
    (See doc M156 for full detials). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1992Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)

    Hat BRENT WALKER GROUP PLC(THE) Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. März 1992Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Scott Barnes
    Euston Square
    Melton Street
    NW1 2EP London
    Praktiker
    Euston Square
    Melton Street
    NW1 2EP London
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    2
    DatumTyp
    15. Nov. 1990Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Scott Barnes
    Euston Square
    Melton Street
    NW1 2EP London
    Praktiker
    Euston Square
    Melton Street
    NW1 2EP London
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0