FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01594324
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • (5510) /
    • (9234) /
    • (9261) /
    • (9272) /

    Wo befindet sich FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o ERNST & YOUNG
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Greater Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALNERY NO. 117 LIMITED29. Okt. 198129. Okt. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2002

    Welche sind die letzten Einreichungen für FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von John Anthony Smith als Sekretär am 18. Mai 2004

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    2 Seiten4.43

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    5 Seiten1.4

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 19. Aug. 2008

    2 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 10. Mai 2009

    2 Seiten3.6

    Ernennung eines Liquidators

    2 Seiten4.31

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Auflösungsaufschub

    1 SeitenL64.04

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    legacy

    1 Seiten287

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    2 Seiten3.6

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Wer sind die Geschäftsführer von FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AHMAD, Saadia
    The Shant Cottage
    Grain Road, Lower Stoke
    ME3 9RF Rochester
    Kent
    Geschäftsführer
    The Shant Cottage
    Grain Road, Lower Stoke
    ME3 9RF Rochester
    Kent
    EnglandBritishCompany Director68185690001
    BRETT, John Francis
    29 Coales Ave
    Whetstone
    LE8 6WB Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    29 Coales Ave
    Whetstone
    LE8 6WB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector107255940001
    DYER, Roger Norman
    41 Malmains Way
    BR3 6SB Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    41 Malmains Way
    BR3 6SB Beckenham
    Kent
    EnglandBritishDirector70297220003
    GARDNER, Richard David
    36 Sunnyhill
    Burbage
    LE10 2SB Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    36 Sunnyhill
    Burbage
    LE10 2SB Leicester
    Leicestershire
    BritishH R Director87927500001
    GUNTER, Victoria
    39 Orient Close
    AL1 1AJ St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    39 Orient Close
    AL1 1AJ St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector91582430001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Sekretär
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    SMITH, John Anthony
    21 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AW London
    Sekretär
    21 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AW London
    BritishDirector3060950001
    WHEELER, Jonathan
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    Sekretär
    19 Glebe Place
    Chelsea
    SW3 5LD London
    British19812400001
    WRIGHT, David William
    The Oast House
    Shernfold Park Farm
    TN3 9DL Frant
    East Sussex
    Sekretär
    The Oast House
    Shernfold Park Farm
    TN3 9DL Frant
    East Sussex
    British83417990001
    BOLLOM, Joseph Edward
    The White House
    Totteridge Common
    N20 8NG London
    Geschäftsführer
    The White House
    Totteridge Common
    N20 8NG London
    BritishChairman & Chief Executive9020500001
    BUCKS, David
    9 Haarlem Road
    W14 0JL London
    Geschäftsführer
    9 Haarlem Road
    W14 0JL London
    BritishMerchant Banker19484480001
    BUTLER, Andrew
    167 Appledore Avenue
    Wollaton
    NG8 2RW Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    167 Appledore Avenue
    Wollaton
    NG8 2RW Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishAccountant76223610001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director36488470001
    CAMPBELL, Joseph
    53 Winchester Avenue
    Great Sankey
    WA5 1XX Warrington
    Lancashire
    Geschäftsführer
    53 Winchester Avenue
    Great Sankey
    WA5 1XX Warrington
    Lancashire
    BritishDirector87427070001
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant12337010002
    CONLAN, John Oliver
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChief Executive9020510001
    DARESBURY, Peter Gilbert, Lord
    Hall Lane Farm
    Daresbury
    WA4 4AF Warrington
    Geschäftsführer
    Hall Lane Farm
    Daresbury
    WA4 4AF Warrington
    EnglandBritishGroup Managing Director5404190003
    DELFONT, Bernard, Lord
    49 York Terrace West
    Regents Park
    NW1 4QA London
    Geschäftsführer
    49 York Terrace West
    Regents Park
    NW1 4QA London
    BritishChairman24166180001
    GRADE, Michael Ian
    Flat 18 Bevedere House
    130 2 Grosvenor Road
    SW1V 3JY London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Bevedere House
    130 2 Grosvenor Road
    SW1V 3JY London
    BritishChief Excutive Channel 4 Telev71289920013
    GRIEVES, John Kerr
    7 Putney Park Avenue
    SW15 5QN London
    Geschäftsführer
    7 Putney Park Avenue
    SW15 5QN London
    EnglandBritishConsultant2846850001
    HODSON, James Patrick
    Top Wild Park Farmhouse
    Brailsford
    DE6 3BP Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Top Wild Park Farmhouse
    Brailsford
    DE6 3BP Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant151575570001
    IRENS, Nicholas James
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    BritishFinance Director65447080002
    KINSEY, Paul Anthony, Me
    Deepdale
    Upper Langwith, Collingham
    LS22 5DQ Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Deepdale
    Upper Langwith, Collingham
    LS22 5DQ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector66872840001
    MILLS, Richard
    Sarn
    Coombe Park
    KT2 7JB Kingston Hill
    Surrey
    Geschäftsführer
    Sarn
    Coombe Park
    KT2 7JB Kingston Hill
    Surrey
    BritishExecutive Director24166160001
    PAYNE, Michael Kenneth
    Knights Yard 4 Plain Gate
    Templars Field Rothley
    LE7 7SQ Leicester
    Geschäftsführer
    Knights Yard 4 Plain Gate
    Templars Field Rothley
    LE7 7SQ Leicester
    BritishDirector-Operations54698120001
    PRIESTLEY, Jennifer
    48 Coniger Road
    SW6 3TA London
    Geschäftsführer
    48 Coniger Road
    SW6 3TA London
    United KingdomBritishChief Executive10742250001
    RAYNE, Max, Lord
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    Geschäftsführer
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    BritishCompany Director35619240001
    RAYNE, Robert Anthony, The Honourable
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    Geschäftsführer
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    EnglandBritishDirector53009350001
    SMITH, John Anthony
    21 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AW London
    Geschäftsführer
    21 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AW London
    EnglandBritishDirector3060950001
    SYMONDS, John Anthony
    126 Newbold Road
    Barlestone
    CV13 0DT Nuneaton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    126 Newbold Road
    Barlestone
    CV13 0DT Nuneaton
    Warwickshire
    BritishAccountant71098230001
    TAMBLYN, Nicholas
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    EnglandBritishCommercial Director27144350003
    WOOLF, John, Sir
    24 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY London
    Geschäftsführer
    24 Thames Quay
    Chelsea Harbour
    SW10 0UY London
    BritishFilm & Television Producer46108280002
    WOOLF, Jonathan Charles
    214 The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Geschäftsführer
    214 The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    United KingdomBritishCompany Director30804260001

    Hat FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 06. Juni 2002
    Geliefert am 12. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including bristol, the works 15 nelson street bristol BS1 2JY t/n ESX253935, derby, destiny & elite colyear street, derby DE1 3EA t/ns DY3039/DY119653.. For further property charged please refer to schedule to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 12. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Mai 2004Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Supplemental deed between first leisure, flc property limited (the lessor), first leisure trading limited (together the tenants), pco 185 limited (counterparty) spv management limited (counterparty shareholder) riverside limited (together with the tenants, the "original guarantors") and the bankrelating to the deed of agreement dated 18 december 1997
    Erstellt am 31. Jan. 2000
    Geliefert am 16. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each guaranteed party to the chargee under the terms of the documents to which it is a party
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest in and to the charged account and the charged balance with the account being interest bearing sterling deposit account sort code 60-92-33 account number 1731386/101 at cibc world markets PLC designated "first leisure" and all related rights accruing therefrom and thereof under the deed with the charged balance being all sums deposited in the charged account and all interest thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A security accession deed
    Erstellt am 31. Jan. 2000
    Geliefert am 05. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due or to become due from the company and each of the other obligors under the finance documents on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Utopia nightclub unit 165 lord square lord street blackburn title number LA390553 all buildings and fixtures (including trade fixtures) first fixed charge all other interests te benefit of all covenants all licences the benefit of all other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lehman Commercial Paper Inc
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 19. Apr. 1999
    Geliefert am 22. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank at its treasury division branch in the name of lloyds bank PLC re:first leisure corporation PLC denominated in sterling designated loan note guarantee and numbered lbf flr 1 and all such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank at its city office branch in the name of lloyds bank PLC re:first leisure corporation PLC denominated in sterling designated sterling designated sterling note guarantee and numbered 1423288 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Erstellt am 30. Mai 1997
    Geliefert am 06. Juni 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement (or otherwise howsoever). The deposit means the debt or debts owing to the company by the bank or any party on the account or accounts numbered 0560567 and all interest (if any).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Further charge
    Erstellt am 03. Okt. 1985
    Geliefert am 15. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a debenture dated 19.01.83 and to an agreement dated 14.01.83. and/or this charge.
    Kurze Angaben
    L/H 5TH floor office haymarket house haymarket leicester.
    Berechtigte Personen
    • Trusthouse Forte Hotels Limited
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juli 1985
    Geliefert am 23. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to an agreement dated 14/01/83 and to a debenture dated 19/01/83.
    Kurze Angaben
    L/H property k/a romeo & juliets nelson street bristol in the county of avon T.N. bl 1206.
    Berechtigte Personen
    • Trusthouse Forte Hotels Limited.
    Transaktionen
    • 23. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 1985
    Geliefert am 18. Apr. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to an agreement dated 14.1.83 and a debenture dated 19.1.83 and this charge.
    Kurze Angaben
    Property known as the worcester county squash club, perdiswell in the city of worcester title no hw 25176.
    Berechtigte Personen
    • Trusthouse Forte Hotels Limited
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 12. Jan. 1984
    Geliefert am 16. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as north middlesex squash rackets club, southbury road enfield.
    Berechtigte Personen
    • Creditanstalt Bankverein.
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 12. Jan. 1984
    Geliefert am 16. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as north middlesex squash rackets club, southbury road enfield.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited.
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Further charge
    Erstellt am 12. Jan. 1984
    Geliefert am 16. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83
    Kurze Angaben
    F/H property known as north middlesex squash club enfield.
    Berechtigte Personen
    • Trusthouse Forte Hotels Limited.
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo & juliet's" birmingham demised by two underleases t/nos wk 150424 & wk 150425.
    Berechtigte Personen
    • Creditanstalt Bankverein
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo & juliet's" birmingham demised by two underleases t/nos wk 150424 & wk 150425.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal.
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to first national boston limited (as agent to the banks named) supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 and a debenture dated 19.1.84.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo & juliet's" birmingham demised by two underleases. T/n wk 150424 and wk 150424.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited(It is Capacity as Agent).
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo & juliet's" birmingham demised by two underleases. T/n wk 150424 and wk 150425.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited.
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo and juliet's" birmingham demised by two underleases. T/n wk 150424 and wk 150425.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo and juliet's" jameson street kingston-upon-hull.
    Berechtigte Personen
    • Creditanstalt Bankverein
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo and juliet's" jameson street kingston-upon-hull.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal.
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to first national boston limited (as agent for the banks) supplemental to a loan agreement dated 14.1.84 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo and juliet's" jameson street, kingston-upon-hull.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited(In Its Capacity as Agent).
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the bank of montreal supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83
    Kurze Angaben
    Property known as "romeo and juliet's" jameson street, kingston-upon-hull.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to bank of montreal supplemental to a loan agreement dated 14.19.83 & adebenture dated 19.1.83
    Kurze Angaben
    Property as "romeo and juliet's" jameson street, kingston-upon-hull.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the bank of montreal supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83
    Kurze Angaben
    Property on the third floor of the darum stone doncaster known as "romeo and juliet's" duke street, doncaster.
    Berechtigte Personen
    • Creditanstalt Bankverein.
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the bank of montreal supplemental a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83
    Kurze Angaben
    Property on the third floor of the darum stone doncaster known as "romeo and juliet's" duke street, doncaster.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Montreal
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to first national boston limited (as agent to the banks named) supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83.
    Kurze Angaben
    Property situate on the third floor of the darum stone doncaster known as "romes and juliet's" duke street doncaster.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited(In Its Capacity as Agent).
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 1984
    Geliefert am 12. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 14.1.83 & a debenture dated 19.1.83
    Kurze Angaben
    Property situate on the third floor of the darum stone doncaster known as "romes and juliet's" duke street doncster.
    Berechtigte Personen
    • First National Boston Limited.
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1984Registrierung einer Belastung

    Hat FIRST LEISURE CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. Juni 2002Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Neville Whitfield
    186 City Road
    London
    Ec1v 2nu
    Praktiker
    186 City Road
    London
    Ec1v 2nu
    Simon Peter Bower
    Rsm Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London
    Praktiker
    Rsm Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London
    Simon Peter Bower
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Rsm Robson Rhodes Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DatumTyp
    12. Juli 2004Antragsdatum
    16. Juli 2010Abschluss der Liquidation
    15. Dez. 2004Beginn der Liquidation
    04. Nov. 2010Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    3
    DatumTyp
    26. Mai 2009Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    09. Feb. 2009Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Praktiker
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0