LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED

LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01597630
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    • (4521) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rok Centre Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Devon
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NINELEGS LIMITED13. Nov. 198113. Nov. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Julian Turnbull als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Sandra Al-Kordi als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 12. Mai 2010

    • Kapital: GBP 223,703
    SH01

    Ernennung von Mr Julian Patrick Turnbull als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Julian Turnbull als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Sandra Joan Al-Kordi als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ross Christie als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    24 SeitenMG01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    1 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    22 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    12 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    24 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AL-KORDI, Sandra Joan
    Rok Centre Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Devon
    Sekretär
    Rok Centre Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Devon
    150190200001
    FOX, Richard John Robert
    41 Schofield Way
    BN23 6HQ Eastbourne
    East Sussex
    Sekretär
    41 Schofield Way
    BN23 6HQ Eastbourne
    East Sussex
    British5073760002
    THEW, Gordon James
    150 Eldred Avenue
    BN1 5EJ Brighton
    East Sussex
    Sekretär
    150 Eldred Avenue
    BN1 5EJ Brighton
    East Sussex
    British4985130001
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Sekretär
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    BAILEY, Michael William John
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    Geschäftsführer
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    British104839850001
    BARRATT, Daniel John
    Applegate The Street
    Wilmington
    BN26 5SQ Polegate
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Applegate The Street
    Wilmington
    BN26 5SQ Polegate
    East Sussex
    British13603120001
    BURKE, Judith Florence
    Chatesgrove
    Cross Colwood Lane
    RH17 5RY Bolney
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Chatesgrove
    Cross Colwood Lane
    RH17 5RY Bolney
    West Sussex
    EnglandBritish4985140002
    CHRISTIE, Ross Arneil
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish106468680002
    GEER, Gerald
    Pantiles Jordans Lane West
    Willingdon
    BN22 0LL Eastbourne
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Pantiles Jordans Lane West
    Willingdon
    BN22 0LL Eastbourne
    East Sussex
    British4985170001
    GOLDING, Terence William
    Upper Standard Cottage
    Rattle Road Westham
    BN24 5DS Pevensey
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Upper Standard Cottage
    Rattle Road Westham
    BN24 5DS Pevensey
    East Sussex
    British98222510001
    HOGG, John
    37 Old Mill Close
    Patcham
    BN1 8WE Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    37 Old Mill Close
    Patcham
    BN1 8WE Brighton
    East Sussex
    British111529080001
    HUNT, Neal Finbar
    8 Moat Farm
    TN2 5XG Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    8 Moat Farm
    TN2 5XG Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandIrish87131100001
    LINFIELD, Martin Kenneth
    Sunsmiles
    26 Middle Mead
    BN44 3RG Steyning
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Sunsmiles
    26 Middle Mead
    BN44 3RG Steyning
    West Sussex
    British104180500001
    LLEWELLYN, David Walter
    Coopers Cottage
    Chiddingly
    BN8 6HD Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Coopers Cottage
    Chiddingly
    BN8 6HD Lewes
    East Sussex
    British6693010001
    LLEWELLYN, John Edward Charles
    Ratton Wood Garnet Drive
    BN20 9AE Eastbourne
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Ratton Wood Garnet Drive
    BN20 9AE Eastbourne
    East Sussex
    British14195440001
    LLEWELLYN, Timothy Charles
    28 Hyde Gardens
    BN21 4PX Eastbourne
    East Sussex
    Geschäftsführer
    28 Hyde Gardens
    BN21 4PX Eastbourne
    East Sussex
    British13603130006
    SNOOK, Garvis David
    Holly House 23 Ashley Road
    Uffculme
    EX15 3AY Cullompton
    Devon
    Geschäftsführer
    Holly House 23 Ashley Road
    Uffculme
    EX15 3AY Cullompton
    Devon
    British70647210001
    TURNBULL, Julian Patrick
    Rok Centre Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    Rok Centre Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Devon
    EnglandEnglish11548360002
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    EnglandEnglish11548360002

    Hat LLEWELLYN MANAGEMENT SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed
    Erstellt am 30. Sept. 2009
    Geliefert am 06. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. März 2009
    Geliefert am 24. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any company to any pension scheme or to any pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    St james retail and business park knaresborough harrowgate t/no NYK352109 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Temple Trustees Limited (The “Security Agent”) as Agent and Trustee for the Pension Trustees
    Transaktionen
    • 24. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. März 2009
    Geliefert am 16. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. März 2009
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 warrior square hastings east sussex t/no ESX83091. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Old mill lane (pratling street) aylesford kent ME20 7DT t/no K284705. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    94 ringwood road eastbourne BN22 8TD t/no ESX83090. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Dyke house 104-114 south street eastbourne t/no EB12740. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 calverley road eastbourne BN21 4SR t/no EB17985. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2A south street eastbourne BN21 4XF t/no EB11254. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16-20 & 22 south street eastbourne t/nos EB15952, ESX83092, EB11738, ESX44759 & ESX83093. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the west side of courtlands road eastbourne BN22 8TS t/nos EB18179 & EB27179. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at waterworks road/moy avenue eastbourne BN22 8LL t/no ESX261622 & EB4212. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    79-83 coborn road london E3 t/no LN62122 and LN131344. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    19 north road portslade west sussex BN21 1ED t/no SX151851. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Erstellt am 09. Aug. 1999
    Geliefert am 10. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title and interest in sub leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 1994
    Geliefert am 04. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or walter llewellyn & sons limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    19 north street, portslade, east sussex t/no: sx 151851.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sub-mortgage
    Erstellt am 23. Sept. 1985
    Geliefert am 11. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An assignment of all monies principal or interest secured by a mortgage dated 31/7/85 on 123,125 & 127 high street sittingbourne kent known as the cedons club. Title no k 592866 see doc M21 for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    • 22. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal sub charge
    Erstellt am 15. Juni 1985
    Geliefert am 15. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property known as land on the east side of court lands road eastbourne, title no eb 22775.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. Okt. 1982
    Geliefert am 08. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on east side of courtlands road, eastbourne, east sussex. Tn: eb 22775.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 31. März 1974
    Geliefert am 25. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £22,000
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north west side of moy avenue eastbourne east sussex.
    Berechtigte Personen
    • D G Bainbridge
    • J E Spriggs
    • J S Bainbridge
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    • 22. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0