AC201 REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAC201 REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01600753
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AC201 REALISATIONS LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ANGLAIR LIMITED20. Okt. 198620. Okt. 1986
    AIRTEC LIMITED27. März 198627. März 1986
    ATC PNEUMATICS LIMITED09. Sept. 198209. Sept. 1982
    DOUBLEBADGE LIMITED30. Nov. 198130. Nov. 1981

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    9 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. März 2015

    8 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. März 2014

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. März 2013

    8 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. März 2012

    6 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Sept. 2011

    6 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. März 2011

    8 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    2 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Sept. 2010

    7 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    11 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    10 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 115 Burrell Road Ipswich Suffolk IP2 8AE* am 09. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 Seiten2.12B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed anglair LIMITED\certificate issued on 31/03/10
    2 SeitenCERTNM

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 23. März 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    10 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    10 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return04. Juli 2007

    legacy

    363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    14 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von AC201 REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Sekretär
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    SHANKS, Alastair Paul Henry
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    Geschäftsführer
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    BritainBritish101167430002
    SHANKS, Alexander Gavin
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    Geschäftsführer
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    ScotlandBritish21890001
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Geschäftsführer
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    Sekretär
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    British52221890002
    PRATT, Cyril Harry
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    British8832470001
    WOOLLHEAD, John Andrew
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    Sekretär
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    British13072060002
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish4250980001
    CHILTON, Albert Edmund
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    Geschäftsführer
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    British6236180002
    FOSTER, Simon
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    British94152980001
    FRYER, Peter Kenneth
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Other79955580001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JACKSON, Frank
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    British10015550001
    KING, Geoffrey Edward
    27 Thirlmere Road
    Barrow On Soar
    LE12 8QQ Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    27 Thirlmere Road
    Barrow On Soar
    LE12 8QQ Loughborough
    Leicestershire
    British10425820001
    LATIMER, Stephen Berjie James
    154 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SD Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    154 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SD Norwich
    Norfolk
    British10425810001
    STANTON, Derek William
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    British10425830001
    URQUHART, Robert Todd
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    Geschäftsführer
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British56397610002

    Hat AC201 REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 5 pinfold road, thurmaston, leicester t/no LT130050. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land k/a 203 to 207 (odd) attercliffe road, sheffield t/nos SYK448819 and SYK343842. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 199/201/203 mile cross lane, norwich t/nos NK21866 and NK6883. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 115 burrell road ipswich t/no SK124923. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and trust debenture
    Erstellt am 07. Okt. 2002
    Geliefert am 09. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any of them to the trustee and or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 08. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 19. Sept. 1983
    Geliefert am 27. Sept. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1983Registrierung einer Belastung
    • 02. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of set off
    Erstellt am 07. Feb. 1983
    Geliefert am 18. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or jackson group PLC to the chargee
    Kurze Angaben
    Sums standing to the credit of the company with lloyds bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    • 02. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AC201 REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. März 2010Beginn der Verwaltung
    20. März 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Caven
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    Praktiker
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    Praktiker
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    2
    DatumTyp
    20. März 2012Beginn der Liquidation
    14. Sept. 2016Soll aufgelöst werden am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Caven
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Praktiker
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    Praktiker
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0