PETER BLACK HOMEWARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PETER BLACK HOMEWARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01604151 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PETER BLACK HOMEWARE LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich PETER BLACK HOMEWARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Keighley West Yorkshire BD21 3BB |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PETER BLACK HOMEWARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PETER BLACK HOMEWARE (WHITEFIELD) LIMITED | 13. Jan. 1987 | 13. Jan. 1987 |
| PETER BLACK HOMEWARE LIMITED | 14. März 1985 | 14. März 1985 |
| J.S. TEXTILES LIMITED | 01. März 1982 | 01. März 1982 |
| DICECREST LIMITED | 15. Dez. 1981 | 15. Dez. 1981 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PETER BLACK HOMEWARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PETER BLACK HOMEWARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Sydney Sagar Kershaw am 13. Jan. 2011 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Sydney Sagar Kershaw am 27. Aug. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Sydney Sagar Kershaw am 25. Aug. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PETER BLACK HOMEWARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETTSCHNEIDER, Ulf Stefan | Geschäftsführer | Shelgate Road SW11 1BA London 35 | United Kingdom | German | 125315710001 | |||||
| KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | Geschäftsführer | Keighley West Yorkshire BD21 3BB | England | British | 1554150010 | |||||
| KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | Sekretär | The Hollies Oakworth BD22 7HL Keighley West Yorkshire | British | 1554150009 | ||||||
| ELLIS, Stephen Mark | Geschäftsführer | 4 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 53625240002 | |||||
| KERSHAW, Christopher Sydney Sagar | Geschäftsführer | The Hollies Oakworth BD22 7HL Keighley West Yorkshire | England | British | 1554150009 | |||||
| KITSON, John Edward | Geschäftsführer | Poplar House Old Road Dunkeswick LS17 9HY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 102500730001 | |||||
| LISTER, Robert Stephen | Geschäftsführer | High Ash Farm West Morton BD20 5UP Keighley West Yorkshire | British | 1554190002 | ||||||
| POOL, Bryan Anthony | Geschäftsführer | Limley House Main Street Kirkby Malzeard HG4 3SD Ripon North Yorkshire | United Kingdom | British | 42350320001 | |||||
| YEWDALL, Neil Stuart | Geschäftsführer | 31 St Helens Lane Adel LS16 8BR Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 17046770002 | |||||
| YEWDALL, Neil Stuart | Geschäftsführer | 9 Long Meadows Bramhope LS16 9DA Leeds West Yorkshire | British | 17046770001 |
Hat PETER BLACK HOMEWARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Erstellt am 07. Juni 1984 Geliefert am 28. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the comapny and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the original deed dated 6/3/78 as amended by this deed | |
Kurze Angaben Specific equitable charge over all estates or interest in any f/h & l/h property other securities belonging to the company in any of its subsidiary companies. Floating security over undertaking and all property and assets & goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 07. Juni 1984 Geliefert am 22. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/hold and l/hold propertes and/or the proceeds of sale fixed and flaoting charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 07. Juni 1984 Geliefert am 22. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties &/or the proceeds of sale thereof all stocks share &/or other security floating charges undertaking and all property and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. & the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Jan. 1983 Geliefert am 20. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all buidlings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Jan. 1983 Geliefert am 06. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges on the:- undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital. With all buidlings fixtures (including trade fixtures). And fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0