EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01605243 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9/10 The Briars Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. März 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Darren Melvin als Geschäftsführer am 17. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin William White als Geschäftsführer am 17. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Ayre als Direktor am 17. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Notification of Elrac Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Martin William White as a person with significant control on 25. Apr. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin William White als Sekretär am 17. Mai 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew John Ellis als Direktor am 17. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Hilton Jones als Direktor am 17. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Paul Earnshaw als Direktor am 17. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Clarendon Road Works Clarendon Road Blackburn BB1 9SS zum 9/10 the Briars, Waterberry Drive Waterlooville England PO7 7YH am 22. Mai 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2020 bis 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYRE, Mark | Geschäftsführer | The Briars Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England | England | British | 129877500001 | |||||
| EARNSHAW, James Paul | Geschäftsführer | The Briars Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England | England | British | 242029700001 | |||||
| ELLIS, Andrew John | Geschäftsführer | The Briars Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England | England | British | 150028400001 | |||||
| JONES, Richard Hilton | Geschäftsführer | The Briars Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England | England | British | 101090610001 | |||||
| GRAHAM, Kathleen | Sekretär | Windy Ridge Wallings Lane, Silverdale LA5 0RZ Carnforth | British | 24150300001 | ||||||
| HOWARTH, Margaret | Sekretär | 4 Hill View BB1 8RA Blackburn | British | 8751710003 | ||||||
| WHITE, Martin William | Sekretär | The Briars, Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England England | British | 105439390001 | ||||||
| HOWARTH, Geoffrey | Geschäftsführer | 25 Goodshaw Avenue Pleckgate BB1 8PF Blackburn Lancashire | British | 8751720002 | ||||||
| HOWARTH, Margaret | Geschäftsführer | 4 Hill View BB1 8RA Blackburn | British | 8751710003 | ||||||
| MELVIN, Darren | Geschäftsführer | The Briars, Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England England | United Kingdom | British | 105439380001 | |||||
| WHITE, Martin William | Geschäftsführer | The Briars, Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England England | United Kingdom | British | 105439390002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Martin William White | 25. Apr. 2017 | Clarendon Road BB1 9SS Blackburn Clarendon Road Works Lancashire England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Elrac Limited | 06. Apr. 2016 | The Briars, Waterberry Drive PO7 7YH Waterlooville 9/10 England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EAST LANCASHIRE REFRIGERATION LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. Nov. 2014 Geliefert am 13. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 1 clarendon road blackburn lancashire title no LA595481. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juli 2008 Geliefert am 22. Juli 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 15. Sept. 2006 Geliefert am 27. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Sept. 2006 Geliefert am 21. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land and buildings on the north side of clarendon road blackburn t/n LA393387. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 02. Nov. 2001 Geliefert am 09. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The initial deposit of £3,632.28 credited to account designation 14062356 with the bank and any addition and any deposit or account of any other currency deriving therdfrom. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 15. Aug. 2000 Geliefert am 23. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of phillips components limited blackburn for £70,696.60 | |
Kurze Angaben The sum of £70,696.60 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 12879002 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Juli 1982 Geliefert am 21. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the north side of clarendon road, blackburn lancashire title no la 393387. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0