CIVICA SOLUTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CIVICA SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01623460 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CIVICA SOLUTIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CIVICA SOLUTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Burston Road Putney SW15 6AR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CIVICA SOLUTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALPHA MICROSYSTEMS (GREAT BRITAIN) LIMITED | 02. Juli 1982 | 02. Juli 1982 |
| REFAL 21 LIMITED | 19. März 1982 | 19. März 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CIVICA SOLUTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CIVICA SOLUTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Juli 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Richard Downing am 04. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Phillip David Rowland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Stoddard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Richard Downing am 27. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CIVICA SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STODDARD, Michael | Sekretär | Walnut Cottage Main Street Hanwell OX17 1HN Banbury Oxfordshire | British | 72002400004 | ||||||
| DOWNING, Simon Richard | Geschäftsführer | 2 Burston Road Putney SW15 6AR London | England | British | 95005230002 | |||||
| ROWLAND, Phillip David | Geschäftsführer | Burston Road Putney SW15 6AR London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 147804670001 | |||||
| DEIGNAN, Susan Elaine | Sekretär | 8 Greenwood Grove Winnersh RG41 5LH Wokingham Berkshire | British | 51701200001 | ||||||
| FROST, Adrian David | Sekretär | 2 Edwards Road B75 5NG Sutton Coldfield West Midlands | British | 74874640001 | ||||||
| GARDENER, Paul Richard | Sekretär | Haddef 21 Deacon Close RG40 1WF Wokingham Berkshire | British | 44726880002 | ||||||
| OSLER, Michael | Sekretär | 31 Beckingham Road GU2 6BT Guildford Surrey | British | 23517900001 | ||||||
| DEIGNAN, Susan Elaine | Geschäftsführer | 8 Greenwood Grove Winnersh RG41 5LH Wokingham Berkshire | British | 51701200001 | ||||||
| GARDENER, Paul Richard | Geschäftsführer | Haddef 21 Deacon Close RG40 1WF Wokingham Berkshire | British | 44726880002 | ||||||
| NODEN, Philip Thomas | Geschäftsführer | Little Mill Cottage Colemere SY12 0QR Ellesmere Shropshire | British | 141537860001 | ||||||
| REYNOLDS, Clarke | Geschäftsführer | 13010 Caminito Bracho Rancho Bernardo California 92128 FOREIGN Usa | Usa | 23517920001 | ||||||
| STODDARD, Michael | Geschäftsführer | Walnut Cottage Main Street Hanwell OX17 1HN Banbury Oxfordshire | England | British | 72002400004 | |||||
| TAYLOR, Jacqueline | Geschäftsführer | 75 Bond Street New Rossington DN11 0XB Doncaster South Yorkshire | British | 7722530001 | ||||||
| TULIO, Douglas John | Geschäftsführer | 901 Summit Drive Laguna Beach 92651 California Usa | American | 37653600001 | ||||||
| WHITE, Peter Ernest | Geschäftsführer | 15 Heronsford Ladybridge NN4 9XG Northampton | British | 49454790001 | ||||||
| WINN, Christopher | Geschäftsführer | Willow Bank Halls Farm Lane Trimpley DY12 1NP Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 15932260001 | |||||
| WINN, Christopher | Geschäftsführer | Willow Bank Halls Farm Lane Trimpley DY12 1NP Bewdley Worcestershire | United Kingdom | British | 15932260001 |
Hat CIVICA SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 2003 Geliefert am 07. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third guarantee & debenture between the chargor company and others and the dresdner bank ag, london branch | Erstellt am 11. Juli 2000 Geliefert am 12. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due owing or incurred by the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on or after the debenture date and under or pursuant to the mezzanine finance documents (all as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A second guarantee and debenture between, amongst others the company (being the chargor) and dresdner bank ag, london branch (as security trustee) | Erstellt am 10. März 2000 Geliefert am 21. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents and mezzanine finance documents (as therein defined), excluding from the above any liability or sum outstanding under the term facility, the loan note guarantee facility, the revolving credit facility and the mezzanine loan agreement and any other liability or sum which would, but for the proviso, cause such covenants and guarantees or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute lawful financial assistance prohibited by section 151 of the act | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 25. März 1996 Geliefert am 28. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CIVICA SOLUTIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0