SSEJ LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSSEJ LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01625376
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SSEJ LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich SSEJ LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    6 Coronet Way
    Centenary Park Eccles
    M50 1RE Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SSEJ LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MONITOR ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED19. Dez. 199619. Dez. 1996
    CLAYTON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED01. Jan. 199101. Jan. 1991
    CLAYTON BOSTOCK HILL & RIGBY LIMITED13. Apr. 198813. Apr. 1988
    BOSTOCK HILL & RIGBY LIMITED20. Aug. 198220. Aug. 1982
    DRUMCARD LIMITED29. März 198229. März 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SSEJ LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für SSEJ LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    2 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    2 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    2 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    2 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    5 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    12 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von SSEJ LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BURNETT, Aileen Ethra Murray
    Petersmuir Road
    East Saltoun
    EH34 5EB Edinburgh
    Farragon
    East Lothian
    Sekretär
    Petersmuir Road
    East Saltoun
    EH34 5EB Edinburgh
    Farragon
    East Lothian
    British135320140001
    WILLIAMS, James Scott
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    United KingdomBritish5664100007
    CUMMINGS, John Alan
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British80054340001
    CUNLIFFE, Peter Robin
    23 Arley Road
    B91 1NJ Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    23 Arley Road
    B91 1NJ Solihull
    West Midlands
    British15717470002
    GRIME, John Roland
    Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3DP Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 3DP Stockport
    Cheshire
    British39112420001
    SMITH, Michael Alan
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Sekretär
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British56298410001
    WILLIAMS, James Scott
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    Sekretär
    The Grange Meadow Lane
    Woodhouses
    DE13 8NP Yoxall
    Staffordshire
    British5664100007
    CARGILL, James Donald
    76 Burntwood Road
    Hammerwich
    WS7 0JW Walsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    76 Burntwood Road
    Hammerwich
    WS7 0JW Walsall
    West Midlands
    British7411100001
    COGGAN, Colin Edgar
    8 Ollison Drive
    Streetly
    B74 3DZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    8 Ollison Drive
    Streetly
    B74 3DZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33798290002
    CUMMINGS, John Alan
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Rosary
    Long Marston
    CV37 8RG Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish80054340001
    ELLIS, Anthony Clive, Dr
    Plot 26 Shannon
    Wilnecote
    B77 1NE Tamworth
    Staffs
    Geschäftsführer
    Plot 26 Shannon
    Wilnecote
    B77 1NE Tamworth
    Staffs
    British45000440001
    GRIFFITHS, Neil Malcolm
    21 Carlton Avenue
    Streetly
    B74 3JF Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    21 Carlton Avenue
    Streetly
    B74 3JF Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish5664080001
    HARRIS, Mary Rose, Dr
    37 Rowley Bank
    ST17 9BA Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    37 Rowley Bank
    ST17 9BA Stafford
    Staffordshire
    EnglandBritish65172920001
    HICKS, Andrew James
    8 Hunters Park
    HP4 2PT Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Hunters Park
    HP4 2PT Berkhamsted
    Hertfordshire
    British33701880001
    KOWALSKI, Thomas Paul
    20555 Lincoln Hills Court
    Beverly Hills
    Michigan
    Usa
    Geschäftsführer
    20555 Lincoln Hills Court
    Beverly Hills
    Michigan
    Usa
    American35139180001
    PATERSON, Elizabeth Ann
    8 David House 142 Court Oak Road
    B17 9AB Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    8 David House 142 Court Oak Road
    B17 9AB Birmingham
    West Midlands
    British45370530001
    PYETT, Nicholas John
    20861 Dundee Drive
    Novi
    Michan 78375
    Usa
    Geschäftsführer
    20861 Dundee Drive
    Novi
    Michan 78375
    Usa
    Us30921690002
    SMITH, Michael Alan
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    68 Bridgewater Road
    Northchurch
    HP4 1LB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British56298410001
    STEVENS, Robert Alan
    4 Aragon Drive
    CV34 6LR Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    4 Aragon Drive
    CV34 6LR Warwick
    Warwickshire
    British53641540001
    THOMAS, William Morgan
    3 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish7411110001
    UHLER, Robert George
    4550 Ponte Verda Drive
    FOREIGN Marietta
    Ga 30067
    Usa
    Geschäftsführer
    4550 Ponte Verda Drive
    FOREIGN Marietta
    Ga 30067
    Usa
    American13528640001

    Hat SSEJ LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 11. Aug. 1995
    Geliefert am 16. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Feb. 1995
    Geliefert am 21. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date and all moneys due or to become due from clayton environmental consultants inc under the terms of a loan and security agreement (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Greyhound Guaranty PLC and/or Finova Capital Corporation
    Transaktionen
    • 21. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 03. Juni 1994
    Geliefert am 14. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 4TH june 1993 guaranteeing the obligations of clayton environmental consultants inc. Under a loan and security agreement dated 4TH june 1993 and all other monies secured by the debenture dated 4TH june 1993
    Kurze Angaben
    All that property as charged by the debenture as set out in form 395 dated 15TH june 1993 (registered) being:-. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lasalle Business Credit Inc.
    Transaktionen
    • 14. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Juni 1993
    Geliefert am 15. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stanchart Business Credit, Inc
    Transaktionen
    • 15. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Aug. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Juni 1993
    Geliefert am 15. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank
    Transaktionen
    • 15. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 08. Juli 1982
    Geliefert am 12. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 1982Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0