SSEJ LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SSEJ LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01625376 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SSEJ LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich SSEJ LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6 Coronet Way Centenary Park Eccles M50 1RE Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SSEJ LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MONITOR ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED | 19. Dez. 1996 | 19. Dez. 1996 |
| CLAYTON ENVIRONMENTAL CONSULTANTS LIMITED | 01. Jan. 1991 | 01. Jan. 1991 |
| CLAYTON BOSTOCK HILL & RIGBY LIMITED | 13. Apr. 1988 | 13. Apr. 1988 |
| BOSTOCK HILL & RIGBY LIMITED | 20. Aug. 1982 | 20. Aug. 1982 |
| DRUMCARD LIMITED | 29. März 1982 | 29. März 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SSEJ LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SSEJ LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SSEJ LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNETT, Aileen Ethra Murray | Sekretär | Petersmuir Road East Saltoun EH34 5EB Edinburgh Farragon East Lothian | British | 135320140001 | ||||||
| WILLIAMS, James Scott | Geschäftsführer | The Grange Meadow Lane Woodhouses DE13 8NP Yoxall Staffordshire | United Kingdom | British | 5664100007 | |||||
| CUMMINGS, John Alan | Sekretär | The Rosary Long Marston CV37 8RG Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 80054340001 | ||||||
| CUNLIFFE, Peter Robin | Sekretär | 23 Arley Road B91 1NJ Solihull West Midlands | British | 15717470002 | ||||||
| GRIME, John Roland | Sekretär | Cerne Abbas 247 Bramhall Lane South Bramhall SK7 3DP Stockport Cheshire | British | 39112420001 | ||||||
| SMITH, Michael Alan | Sekretär | 68 Bridgewater Road Northchurch HP4 1LB Berkhamsted Hertfordshire | British | 56298410001 | ||||||
| WILLIAMS, James Scott | Sekretär | The Grange Meadow Lane Woodhouses DE13 8NP Yoxall Staffordshire | British | 5664100007 | ||||||
| CARGILL, James Donald | Geschäftsführer | 76 Burntwood Road Hammerwich WS7 0JW Walsall West Midlands | British | 7411100001 | ||||||
| COGGAN, Colin Edgar | Geschäftsführer | 8 Ollison Drive Streetly B74 3DZ Sutton Coldfield West Midlands | British | 33798290002 | ||||||
| CUMMINGS, John Alan | Geschäftsführer | The Rosary Long Marston CV37 8RG Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 80054340001 | |||||
| ELLIS, Anthony Clive, Dr | Geschäftsführer | Plot 26 Shannon Wilnecote B77 1NE Tamworth Staffs | British | 45000440001 | ||||||
| GRIFFITHS, Neil Malcolm | Geschäftsführer | 21 Carlton Avenue Streetly B74 3JF Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 5664080001 | |||||
| HARRIS, Mary Rose, Dr | Geschäftsführer | 37 Rowley Bank ST17 9BA Stafford Staffordshire | England | British | 65172920001 | |||||
| HICKS, Andrew James | Geschäftsführer | 8 Hunters Park HP4 2PT Berkhamsted Hertfordshire | British | 33701880001 | ||||||
| KOWALSKI, Thomas Paul | Geschäftsführer | 20555 Lincoln Hills Court Beverly Hills Michigan Usa | American | 35139180001 | ||||||
| PATERSON, Elizabeth Ann | Geschäftsführer | 8 David House 142 Court Oak Road B17 9AB Birmingham West Midlands | British | 45370530001 | ||||||
| PYETT, Nicholas John | Geschäftsführer | 20861 Dundee Drive Novi Michan 78375 Usa | Us | 30921690002 | ||||||
| SMITH, Michael Alan | Geschäftsführer | 68 Bridgewater Road Northchurch HP4 1LB Berkhamsted Hertfordshire | British | 56298410001 | ||||||
| STEVENS, Robert Alan | Geschäftsführer | 4 Aragon Drive CV34 6LR Warwick Warwickshire | British | 53641540001 | ||||||
| THOMAS, William Morgan | Geschäftsführer | 3 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 7411110001 | |||||
| UHLER, Robert George | Geschäftsführer | 4550 Ponte Verda Drive FOREIGN Marietta Ga 30067 Usa | American | 13528640001 |
Hat SSEJ LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 11. Aug. 1995 Geliefert am 16. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Feb. 1995 Geliefert am 21. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date and all moneys due or to become due from clayton environmental consultants inc under the terms of a loan and security agreement (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 03. Juni 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 4TH june 1993 guaranteeing the obligations of clayton environmental consultants inc. Under a loan and security agreement dated 4TH june 1993 and all other monies secured by the debenture dated 4TH june 1993 | |
Kurze Angaben All that property as charged by the debenture as set out in form 395 dated 15TH june 1993 (registered) being:-. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Juni 1993 Geliefert am 15. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Juni 1993 Geliefert am 15. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 08. Juli 1982 Geliefert am 12. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0