MOST MOTOR COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOST MOTOR COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01627184
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOST MOTOR COMPANY LIMITED?

    • (5010) /

    Wo befindet sich MOST MOTOR COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MOST MOTOR COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CULVER'S (HYDE) LIMITED05. Apr. 198205. Apr. 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOST MOTOR COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2002

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOST MOTOR COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2002

    5 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2001

    5 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2000

    6 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 1999

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 1997

    15 SeitenAA

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 1996

    16 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363s

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 1995

    8 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    4 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von MOST MOTOR COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COOP, Barbara Ann
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Sekretär
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    British5405710002
    COOP, Barbara Ann
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    BritishCompany Director5405710002
    COOP, Duncan Paul
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    BritishCompany Director72495290001
    COOP, Duncan Barrie
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director5405720001
    COOP, Duncan Barrie
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Sekretär
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    British5405720001
    BRADLEY, Wayne
    214 Stakehill Lane
    Slattocks
    M24 2RZ Middleton
    Manchester
    Geschäftsführer
    214 Stakehill Lane
    Slattocks
    M24 2RZ Middleton
    Manchester
    BritishCompany Director30267700001
    COOP, Duncan Paul
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Tandle Hill Road
    Royton
    OL2 5UU Oldham
    Lancashire
    BritishDirector72495290001

    Hat MOST MOTOR COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating charge
    Erstellt am 25. Apr. 1995
    Geliefert am 11. Mai 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All used motor vehicles owned by the company from time to time and with all guarantees and warranties relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juni 1986
    Geliefert am 27. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over l/hold land & buildings k/a 61-63, dowson road, hyde, cheshire together with all fixtures whatsoever now or at any time thereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    Mortgage debenture
    Erstellt am 22. Apr. 1986
    Geliefert am 25. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at dowson road garside street and markland street hyde tameside greater manchester together with all all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures stocks & shares & other securities (see doc M15 for details).
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    By borrower with one or more guarantors mortgage debenture
    Erstellt am 24. Jan. 1985
    Geliefert am 25. Jan. 1985
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over land and buildings at dowson road garside street and markland street hyde tameside greater manchester together with all thereon and all fixtures whatsoever now or at any time thereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as difined by section 5 of the bills of sale act 1878 floating charge over goodwill, stocks, shares & securities (see doc M14 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 24. Jan. 1983
    Geliefert am 26. Jan. 1983
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including land at dowson road garside street & markland street hyde, greater manchester & buildings erected thereon together with all all fixtures whatsover now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1983Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0