WILLIAMS LEA GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WILLIAMS LEA GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01627560 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Darwin House Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CONSTAT EIGHT LIMITED | 07. Apr. 1982 | 07. Apr. 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Feb. 2027 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 03. März 2027 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 17. Feb. 2026 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2026 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Eric Hess am 03. Dez. 2025 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 18 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 69 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung der Bestätigungserklärung vom 17. Feb. 2025 | 3 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||||||
17/02/25 Statement of Capital gbp 500765.14159 | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Darwin House Leeds Valley Park Savannah Way Leeds LS10 1AB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Eric Hess als Direktor am 31. Jan. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 10 Seiten | MA | ||||||||||||||
Ernennung von Deborah Louise Steiner als Direktor am 31. Jan. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 016275600007 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 016275600009 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Notification of Rrd Uk Corporation Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2025 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Wertheimer Uk Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2025 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Dez. 2024
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Dez. 2024
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mrs Jenni Nicola Hardy als Direktor am 25. Nov. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Mark Walsh als Geschäftsführer am 08. Nov. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Thomas Mark Walsh als Direktor am 24. Okt. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDY, Jenni Nicola | Geschäftsführer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | England | British | 325437240001 | |||||||||
| HESS, Eric | Geschäftsführer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | United States | American | 332344630001 | |||||||||
| MORGAN, Nicholas | Geschäftsführer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | United Kingdom | British | 300650740001 | |||||||||
| STEINER, Deborah Louise | Geschäftsführer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | United States | American | 332213960001 | |||||||||
| WIGGINS, Erin Allen | Geschäftsführer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | United States | American | 326774540001 | |||||||||
| BARTON, Justin Glenn | Sekretär | 2 Stevenage Road SW6 6ER London | British | 42636200002 | ||||||||||
| BARTON, Justin Glenn | Sekretär | 2 Stevenage Road SW6 6ER London | British | 42636200002 | ||||||||||
| DUNCAN, William Grant | Sekretär | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | British | 75956440002 | ||||||||||
| LEVERICK, Christopher | Sekretär | 6 Nelsons Yard NW1 7RN London | English | 71047970001 | ||||||||||
| LI, Jane | Sekretär | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 202696950001 | |||||||||||
| WILLIAMS, Sean Mountford Graham | Sekretär | 31 Sterndale Road W14 0HT London | British | 29952810001 | ||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
| AGHOGHOVBIA, Frank | Geschäftsführer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | United Kingdom | British | 261215990001 | |||||||||
| APPEL, Frank | Geschäftsführer | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | German | 125774440001 | ||||||||||
| BARRY, Thomas | Geschäftsführer | 29 Ashchurch Park Villas W12 9SP London | British | 56618350003 | ||||||||||
| BARTON, Justin Glenn | Geschäftsführer | 2 Stevenage Road SW6 6ER London | England | British | 42636200002 | |||||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | 4 Penhale Close BR6 9XS Orpington Kent | British | 82534740001 | ||||||||||
| COWARD, Richard Stanley | Geschäftsführer | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | United Kingdom | British | 199946190001 | |||||||||
| DAVEY, Conor James | Geschäftsführer | Poland Street W1F 8PR London 1-5 United Kingdom | United Kingdom | British | 168716980001 | |||||||||
| DAVEY, Conor James | Geschäftsführer | 9 Donovan Avenue Muswell Hill N10 2JU London | British | 103028760001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Stephen James | Geschäftsführer | Hughenden Close Denner Hill HP16 0JJ Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 92784240001 | |||||||||
| EDWARDS, Bruce Allan | Geschäftsführer | St John's Lane EC1M 4NA London 29 England | United Kingdom | American | 130277240002 | |||||||||
| ELLERTON, Daniel Robin | Geschäftsführer | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | United Kingdom | British | 190567050001 | |||||||||
| GERDES, Juergen | Geschäftsführer | Am Berghang 11a FOREIGN Bonn 53229 Germany | German | 116247450001 | ||||||||||
| GRAHAM, Paul Harry | Geschäftsführer | Poland Street W1F 8PR London 1-5 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 135634790002 | |||||||||
| GRIFFITHS, Timothy Philip | Geschäftsführer | Eastbourne Terrace W2 6LG London 10 United Kingdom | England | British | 9091580003 | |||||||||
| HANKS, Richard | Geschäftsf ührer | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | United States | British,American | 298484960001 | |||||||||
| HOOK, Jeremy Hamilton | Geschäftsführer | Poland Street Soho W1F 8PR London 1-5 England | England | British | 80045690001 | |||||||||
| INNES KER, Katherine Christina Mary, Lady | Geschäftsführer | Battlesden House MK17 9HW Battlesden Bedfordshire | British | 60329150001 | ||||||||||
| KASSLER, David Nicholas | Geschäftsführer | Poland Street Soho W1F 8PR London 1-5 England | England | British,American | 139908820007 | |||||||||
| KNAPPIK, Klaus Michael | Geschäftsführer | Am Agnesstift 13 FOREIGN Bonn 53117 Germany | German | 110714840001 | ||||||||||
| LANE, Angela Claire | Geschäftsführer | Old Manor Farmhouse London Lane, Avon BH23 7BL Christchurch Dorset | England | British | 72210150001 | |||||||||
| LANGE, Juergen | Geschäftsführer | Von Stauffenberg Weg 5 Meckenheim 53340 Germany | German | 116247910001 | ||||||||||
| LEVERICK, Christopher | Geschäftsführer | 6 Nelsons Yard NW1 7RN London | England | English | 71047970001 | |||||||||
| MACKIE, Brian Robert | Geschäftsführer | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Scotland | British | 173446330002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WILLIAMS LEA GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rrd Uk Corporation Limited | 31. Jan. 2025 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Wertheimer Uk Limited | 01. Nov. 2021 | Leeds Valley Park Savannah Way LS10 1AB Leeds Darwin House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr David Nicholas Kassler | 01. Dez. 2017 | Lowther Road SW13 9NW London 86 England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British,American Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Williams Lea Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Richard Stanley Coward | 06. Apr. 2016 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Stuart Dudley Trood | 06. Apr. 2016 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Daniel Robin Ellerton | 06. Apr. 2016 | 2 Leman Street E1 8FA London Aldgate Tower England | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Williams Lea Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Wells Street W1A 3AE London 55 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0