MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01633413 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quay House The Ambury BA1 1UA Bath |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Ernennung von Mrs Penelope Ladkin-Brand als Direktor am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Oliver James Foster als Direktor am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nial Ferguson als Direktor am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Burton als Geschäftsführer am 09. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Austin Haley als Geschäftsführer am 09. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Penelope Ladkin-Brand als Sekretär am 09. Juli 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Austin Haley als Sekretär am 09. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. März 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Austin Haley als Sekretär am 05. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nina Samantha Day als Sekretär am 05. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Austin Haley als Direktor am 01. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Beauford Court 30 Monmouth Street Bath BA1 2BW zum Quay House the Ambury Bath BA1 1UA am 01. Aug. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr. Matthew James Burton als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Harding als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Zillah Ellen Byng-Maddick als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADKIN-BRAND, Penelope | Sekretär | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | 199242200001 | |||||||
BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | Scottish | Director | 182681640001 | ||||
FERGUSON, Nial Terence | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | England | British | Company Director | 188612770001 | ||||
FOSTER, Oliver James | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | England | British | Management Accountant | 199325990001 | ||||
LADKIN-BRAND, Penelope | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | England | British | Company Director | 198181890001 | ||||
BURTON, Susannah Jane | Sekretär | Shell Orchard The Street Chilcompton BA3 4HB Radstock Somerset | British | Finance Director | 79959930001 | |||||
CAMPBELL, Tim | Sekretär | 7 Lawn Lane Little Downham CB6 2TS Ely Cambridgeshire | British | 54474070001 | ||||||
DAY, Nina Samantha | Sekretär | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 175452310001 | |||||||
HALEY, Richard Austin | Sekretär | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 193394060001 | |||||||
LINKINS, Ian | Sekretär | Hackless House Murhill Limpley Stoke BA3 6HH Bath | British | Company Director | 22968220002 | |||||
MILLAR, Mark Falcon | Sekretär | Hollybush House Bannerdown Road Batheaston BA1 7ND Bath Bath And North East Somerset | British | 84701400002 | ||||||
BOWMAN, John Reid | Geschäftsführer | 5 Hamilton Road BA1 5SB Bath Bath And North East Somerset | England | British | Finance Director | 79292840001 | ||||
BURTON, Matthew James, Mr. | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | Wales | British | Group Financial Controller | 188612600001 | ||||
BURTON, Susannah Jane | Geschäftsführer | Shell Orchard The Street Chilcompton BA3 4HB Radstock Somerset | British | Finance Director | 79959930001 | |||||
DAY, Terence Albert | Geschäftsführer | 97 New Road Haslingfield CB3 7LP Cambridge Cambridgeshire | British | Publisher | 1500970001 | |||||
HALEY, Richard Austin | Geschäftsführer | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | Chief Financial Officer | 191702530001 | ||||
HARDING, Graham David | Geschäftsführer | Beauford Court 30 Monmouth Street BA1 2BW Bath | England | British | Finance Director | 97729390001 | ||||
HILL, Dennis William | Geschäftsführer | 12 Mill Hill End Hilton PE28 9NX Huntingdon Cambridgeshire | England | British | Publisher | 1464090001 | ||||
INGHAM, Gregory John | Geschäftsführer | Avonstone Bathampton Lane Bathampton BA2 6SW Bath | United Kingdom | British | Director | 109991380001 | ||||
LINKINS, Ian | Geschäftsführer | Hackless House Murhill Limpley Stoke BA3 6HH Bath | British | Company Director | 22968220002 |
Hat MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Erstellt am 24. Juli 1989 Geliefert am 10. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H alexander house, (formerly k/as kingfisher house) ely, cambs. Goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 15. Juni 1989 Geliefert am 19. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 01. Nov. 1988 Geliefert am 16. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 24. Juni 1988 Geliefert am 13. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 32 mulberry way ely, cambridgeshire together with all buildings and fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 16. Nov. 1986 Geliefert am 27. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juli 1983 Geliefert am 04. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0