MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED

MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01633413
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Quay House
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Ernennung von Mrs Penelope Ladkin-Brand als Direktor am 09. Juli 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Oliver James Foster als Direktor am 09. Juli 2015

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Nial Ferguson als Direktor am 09. Juli 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Matthew James Burton als Geschäftsführer am 09. Juli 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Austin Haley als Geschäftsführer am 09. Juli 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Penelope Ladkin-Brand als Sekretär am 09. Juli 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Richard Austin Haley als Sekretär am 09. Juli 2015

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. März 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    3 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Ernennung von Mr Richard Austin Haley als Sekretär am 05. Dez. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Nina Samantha Day als Sekretär am 05. Dez. 2014

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Richard Austin Haley als Direktor am 01. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Beauford Court 30 Monmouth Street Bath BA1 2BW zum Quay House the Ambury Bath BA1 1UA am 01. Aug. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    13 SeitenAA

    Ernennung von Mr. Matthew James Burton als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Graham Harding als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Zillah Ellen Byng-Maddick als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LADKIN-BRAND, Penelope
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Sekretär
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    199242200001
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Geschäftsführer
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandScottishDirector182681640001
    FERGUSON, Nial Terence
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Geschäftsführer
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    EnglandBritishCompany Director188612770001
    FOSTER, Oliver James
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Geschäftsführer
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    EnglandBritishManagement Accountant199325990001
    LADKIN-BRAND, Penelope
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Geschäftsführer
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    EnglandBritishCompany Director198181890001
    BURTON, Susannah Jane
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    Sekretär
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    BritishFinance Director79959930001
    CAMPBELL, Tim
    7 Lawn Lane
    Little Downham
    CB6 2TS Ely
    Cambridgeshire
    Sekretär
    7 Lawn Lane
    Little Downham
    CB6 2TS Ely
    Cambridgeshire
    British54474070001
    DAY, Nina Samantha
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Sekretär
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    175452310001
    HALEY, Richard Austin
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Sekretär
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    193394060001
    LINKINS, Ian
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    Sekretär
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    BritishCompany Director22968220002
    MILLAR, Mark Falcon
    Hollybush House
    Bannerdown Road Batheaston
    BA1 7ND Bath
    Bath And North East Somerset
    Sekretär
    Hollybush House
    Bannerdown Road Batheaston
    BA1 7ND Bath
    Bath And North East Somerset
    British84701400002
    BOWMAN, John Reid
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    Geschäftsführer
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritishFinance Director79292840001
    BURTON, Matthew James, Mr.
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Geschäftsführer
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    WalesBritishGroup Financial Controller188612600001
    BURTON, Susannah Jane
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    Geschäftsführer
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    BritishFinance Director79959930001
    DAY, Terence Albert
    97 New Road
    Haslingfield
    CB3 7LP Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    97 New Road
    Haslingfield
    CB3 7LP Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishPublisher1500970001
    HALEY, Richard Austin
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Geschäftsführer
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer191702530001
    HARDING, Graham David
    Beauford Court
    30 Monmouth Street
    BA1 2BW Bath
    Geschäftsführer
    Beauford Court
    30 Monmouth Street
    BA1 2BW Bath
    EnglandBritishFinance Director97729390001
    HILL, Dennis William
    12 Mill Hill End
    Hilton
    PE28 9NX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    12 Mill Hill End
    Hilton
    PE28 9NX Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishPublisher1464090001
    INGHAM, Gregory John
    Avonstone
    Bathampton Lane Bathampton
    BA2 6SW Bath
    Geschäftsführer
    Avonstone
    Bathampton Lane Bathampton
    BA2 6SW Bath
    United KingdomBritishDirector109991380001
    LINKINS, Ian
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    Geschäftsführer
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    BritishCompany Director22968220002

    Hat MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 24. Juli 1989
    Geliefert am 10. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H alexander house, (formerly k/as kingfisher house) ely, cambs. Goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 17. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 15. Juni 1989
    Geliefert am 19. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    • 02. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Nov. 1988
    Geliefert am 16. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juni 1988
    Geliefert am 13. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    32 mulberry way ely, cambridgeshire together with all buildings and fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 17. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Nov. 1986
    Geliefert am 27. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 30. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 1983
    Geliefert am 04. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    • 30. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0