K.W. LINFOOT PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameK.W. LINFOOT PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01634914
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von K.W. LINFOOT PLC?

    • (4521) /

    Wo befindet sich K.W. LINFOOT PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BWC BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von K.W. LINFOOT PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NELSONBRIDGE LIMITED12. Mai 198212. Mai 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von K.W. LINFOOT PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für K.W. LINFOOT PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2013

    3 Seiten3.6

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    21 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Dez. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Dez. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. Sept. 2012

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Juni 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. Sept. 2011

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2012

    3 Seiten3.6

    legacy

    3 SeitenMG02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Dez. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Juni 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Juni 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2011

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. Sept. 2010

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Juni 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. März 2010

    3 Seiten3.6

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    10 Seiten2.34B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    6 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    34 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.15B/2.14B

    10 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten405(1)

    Wer sind die Geschäftsführer von K.W. LINFOOT PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BLAND, Richard James
    6 Loxley Court
    S6 4SF Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    6 Loxley Court
    S6 4SF Sheffield
    South Yorkshire
    British124058180001
    BLAND, Richard James
    6 Loxley Court
    S6 4SF Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    6 Loxley Court
    S6 4SF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director124058180001
    DEAN, Richard Michael
    Lock House Lane
    Earswick
    YO32 9FT York
    4
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lock House Lane
    Earswick
    YO32 9FT York
    4
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Engineer135652840001
    HILDRETH, Christopher John
    The Birches 12b The Village
    Wigginton
    YO32 2PJ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Birches 12b The Village
    Wigginton
    YO32 2PJ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishSurveyor97851800002
    LINFOOT, Kevin William
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bishopthorpe Garth
    Sim Balk Lane Bishopthorpe
    YO23 2UE York
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director51219600001
    LUSCOMBE, Michael
    The Gables
    79 Main Street Escrick
    YO19 6JP York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Gables
    79 Main Street Escrick
    YO19 6JP York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director54350120005
    BROOK, John Anthony
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    Sekretär
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    British38922990001
    LINFOOT, Hilary
    11 Chessingham Gardens
    Tadcaster Road
    YO2 1XE York
    North Yorkshire
    Sekretär
    11 Chessingham Gardens
    Tadcaster Road
    YO2 1XE York
    North Yorkshire
    British5270690001
    MITTON, Charles Donald
    3 Buttacre Lane
    Askham Richard
    YO23 3PE York
    Sekretär
    3 Buttacre Lane
    Askham Richard
    YO23 3PE York
    BritishAccountant94342250002
    MURDOCK, Paul George Ashley
    Nidd Cote York Road
    Moor Monkton Nr York
    YO5 8JJ York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Nidd Cote York Road
    Moor Monkton Nr York
    YO5 8JJ York
    North Yorkshire
    BritishAccountant39283340001
    SHERWOOD, Geoffrey
    69 Green Lane
    Ouzlewell Green Lofthouse
    WF3 3QH Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    69 Green Lane
    Ouzlewell Green Lofthouse
    WF3 3QH Wakefield
    West Yorkshire
    British39991700001
    BARBER, Derek
    Whenby House 15 Garths End
    Pocklington
    YO42 2JA York
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    Whenby House 15 Garths End
    Pocklington
    YO42 2JA York
    East Yorkshire
    BritishConstruction Director60083420001
    BARDY, Beverley Dawn
    The Laurels Monk Stray
    Malton Road
    YO3 9TD York
    Geschäftsführer
    The Laurels Monk Stray
    Malton Road
    YO3 9TD York
    BritishSales Director45298430001
    BROOK, John Anthony
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    Geschäftsführer
    2 Coggan Way
    Bishopthorpe
    YO23 2QX York
    BritishFinance Director38922990001
    CHILCOTT, Christopher Matthew
    52 Stratford Way
    Huntington
    YO3 9YW York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    52 Stratford Way
    Huntington
    YO3 9YW York
    Yorkshire
    BritishConstruction Director64110970001
    CORDOCK, Paul Simpson
    23 Durlston Drive
    Strensall
    YO32 5AT York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    23 Durlston Drive
    Strensall
    YO32 5AT York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishSurveyor39283420001
    FEELEY, Gerard Michael
    12 Woodland Mews
    Thorp Arch
    LS23 7DA Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Woodland Mews
    Thorp Arch
    LS23 7DA Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCommercial Director141174950001
    FORTH, Michael
    19 Lilac Avenue
    Hull Road
    YO10 3AS York
    Geschäftsführer
    19 Lilac Avenue
    Hull Road
    YO10 3AS York
    BritishTechnical Director45298630001
    HOLLIDAY, James Thomas
    51 Godwins Way
    Stamford Bridge
    YO41 1DA York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    51 Godwins Way
    Stamford Bridge
    YO41 1DA York
    North Yorkshire
    BritishManaging Director70002030002
    WADDINGTON, David Michael
    The Chestnuts
    Main Street Bishop Monkton
    HG3 3QP Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Chestnuts
    Main Street Bishop Monkton
    HG3 3QP Harrogate
    North Yorkshire
    UkBritishSales Marketing Director80348000002

    Hat K.W. LINFOOT PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 08. Dez. 2008
    Geliefert am 17. Dez. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kevin William Linfoot
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 24. Juli 2008
    Geliefert am 12. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of equitable charge, charged investments and any income or other benefits deriving therefrom, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Frasers Ventures LTD
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (6) comprising 2 car parking spaces and an attached area of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (3) comprising 3 car parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking space (2) comprising 3 car parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking space (1) comprising 1 car parking space of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (7) comprising 2 parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 14TH and 15TH floor offices of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (9) comprising 2 car parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (4) comprising 3 car parking spaces and 2 areas of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (8) comprising 2 car parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (10) comprising 3 car parking spaces and a small triangular area of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (5) comprising car parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 2008
    Geliefert am 10. Mai 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parking spaces (ii) comprising 2 and a half car parking spaces of whitehall waterfront, riverside way, leeds by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Feb. 2008
    Geliefert am 07. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit A3 whitehall waterfront, riverside way, whitehall road, leeds including all rights attached or appurtenant to it and all buildings, erections, fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 02. Apr. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 30. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
      • Aktenzeichen 3
      • Aktenzeichen 4
    Legal charge
    Erstellt am 05. Feb. 2008
    Geliefert am 07. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Britania house york place leeds including all rights attached and appurtenant to it and all buildings,erections,fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 2
    A mortgage of a share in a limited liability partnership
    Erstellt am 15. Juni 2007
    Geliefert am 02. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigns all of its present and future right title and interest in the capital and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 02. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Share charge
    Erstellt am 19. Feb. 2007
    Geliefert am 21. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge all the shares together with all distribution rights from time to time accruing thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the east of acaster lane bishopthorpe york,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of acaster lane bishopthorpe york,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 2007
    Geliefert am 31. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land adjacent to york racecourse bishopthorpe york,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 16. Feb. 2006
    Geliefert am 21. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of its right, title and interest in and to the rental income being the aggregate of all amounts (exclusive of vat) paid to or for the benefit or account of the assignor in connection with the letting of all or any part of the property k/a britannia house, york place, leeds t/no. WYK691562. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over account
    Erstellt am 16. Feb. 2006
    Geliefert am 21. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge the security assets being all the rights, title and interests of the chargor in the deposit and the account together with all interest thereon and all rights, benefits and proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC T/a Yorkshire Bank
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Mai 2005
    Geliefert am 20. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Britannia house york place leeds (basement, part lower ground floor and part upper ground floor) t/no WYK691562. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 20. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Feb. 2004
    Geliefert am 21. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14TH and 15TH floors whitehall waterfront riverside way leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat K.W. LINFOOT PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Feb. 2009Beginn der Verwaltung
    23. Juni 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Andrew Whitwam
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Praktiker
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Gary E Blackburn
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    Leeds
    Ls1 2ru
    Praktiker
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    Leeds
    Ls1 2ru
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lindsey J Cooper
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Receiver Manager
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Russell Stewart Cash
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Receiver Manager
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lindsey J Cooper
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Receiver Manager
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Russell Stewart Cash
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Receiver Manager
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lindsey J Cooper
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Receiver Manager
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Russell Stewart Cash
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Receiver Manager
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    5
    DatumTyp
    23. Juni 2009Beginn der Liquidation
    06. Juni 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gary E Blackburn
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Praktiker
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Paul Stanley
    C/O Begbies Traynor (Central) 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Praktiker
    C/O Begbies Traynor (Central) 340 Deansgate
    M3 4LY Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0