DEAN & DYBALL MARINE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DEAN & DYBALL MARINE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01641006 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tower Bridge House St. Katharines Way E1W 1DD London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DEAN AND DYBALL SHIPPING LIMITED | 05. Nov. 1982 | 05. Nov. 1982 |
FOLBROWN LIMITED | 03. Juni 1982 | 03. Juni 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Endeavour House Crow Arch Lane Ringwood Hampshire BH24 1PN am 14. Juni 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Richard Johnson am 28. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Murray John Easton als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Crawford als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Emma Campbell als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Morris als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Philip Hugh Morris am 11. Apr. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DEAN & DYBALL MARINE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL, Emma | Sekretär | St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House | 155195410001 | |||||||
EASTON, Murray John | Geschäftsführer | St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House | England | British | Director | 62486170001 | ||||
JOHNSON, Mark Richard | Geschäftsführer | St. Katharines Way E1W 1DD London Tower Bridge House | United Kingdom | British | Director | 61083530002 | ||||
FLINT, Henry Lawrence | Sekretär | Orchard End House Orchard End Bulford SP4 9EA Salisbury Wiltshire | British | Director | 78490580001 | |||||
FLINT, Henry Lawrence | Sekretär | Orchard End House Orchard End Bulford SP4 9EA Salisbury Wiltshire | British | Finance Director | 78490580001 | |||||
MACINTOSH, Kenneth | Sekretär | Woodpecker Cottage Keysworth BH20 7BH Wareham Dorset | British | 9297490001 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Shore Road PO18 8HZ Bosham Cob Cottage West Sussex | British | 34131020003 | ||||||
MORRIS, Philip Hugh | Sekretär | Crow Arch Lane BH24 1PN Ringwood Endeavour House Hampshire | British | 9233330003 | ||||||
BEACH, Philip Graham | Geschäftsführer | Cobblestones Ducky Lane Landrake PL12 5DL Saltash Cornwall | British | Director | 9432480001 | |||||
CRAWFORD, Andrew | Geschäftsführer | Hawkswood 28 Branksome Hill Road BH4 9LD Bournemouth Dorset | United Kingdom | British | Director | 17276890001 | ||||
DYBALL, Adrian Stuart Brennan | Geschäftsführer | 4 Cornwall Road TW1 3LS Twickenham London | British | Company Director | 58499000002 | |||||
DYBALL, Peter Brennan | Geschäftsführer | West Park Farm Colehill BH16 6BS Lytchett Matravers Dorset | British | Director | 9289300001 | |||||
FLINT, Henry Lawrence | Geschäftsführer | Orchard End House Orchard End Bulford SP4 9EA Salisbury Wiltshire | England | British | Finance Director | 78490580001 | ||||
GUSH, William James | Geschäftsführer | 56 Neal Road West Kingsdown TN15 6DG Sevenoaks Kent | England | British | Director | 51427940001 | ||||
HIRST, Martin Beverley Bodenham | Geschäftsführer | Treview Windfield Drive Winchester Hill SO41 0RA Romsey Hampshire | England | British | Director | 9289310002 | ||||
MCNAUGHTON, Andrew James | Geschäftsführer | 8 Sparrow Way RH15 9UL Burgess Hill West Sussex | British | Civil Engineer | 101231740001 | |||||
O KANE, Roger Casimir Bradley | Geschäftsführer | 4 Ameysford Road Ferndown BH22 9QA Wimborne Dorset | British | Company Director | 74572290001 | |||||
PEASLAND, Michael John | Geschäftsführer | 48 Bathgate Road Wimbledon SW19 5PJ London | United Kingdom | British | Director | 714450006 | ||||
WHEELER, Brian Arthur | Geschäftsführer | Ludwell House Ludwell Lane Waltham Chase SO32 2NP Southampton Hampshire | British | Director | 2810790001 | |||||
WHITE, Brian Alexander | Geschäftsführer | 57 Carrington Lane Milford On Sea SO41 0RA Lymington Hampshire | British | Director | 9432490001 |
Hat DEAN & DYBALL MARINE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
An omnibus guarantee and set-off agreement dated 23 january 2002 and | Erstellt am 16. Dez. 2008 Geliefert am 24. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/01/2002 | Erstellt am 20. Sept. 2005 Geliefert am 22. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present and future account of the company with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of ship | Erstellt am 31. März 1994 Geliefert am 14. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage | |
Kurze Angaben 64 shares in the registered ship k/a witton ii registered at the port of liverpool with official number 704461 together with her boats and appurtenances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of covenant | Erstellt am 31. März 1994 Geliefert am 07. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £350,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The british ship named whitten ii registered at the port of liverpool official number 704461. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 26. Nov. 1993 Geliefert am 15. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage | |
Kurze Angaben Sixty four sixty fourth shares of and in the ship "rock supplies barge no.1" Registered at the port of hull official number 720323 year number 15 in 1992. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of covenant | Erstellt am 26. Nov. 1993 Geliefert am 15. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All insurances and earnings of rock supplies barge no.1 Registered at hull official no.720323. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 27. Nov. 1992 Geliefert am 02. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 04. Nov. 1986 Geliefert am 19. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current. | |
Kurze Angaben 1968, motor tanker, single screw "reedness" official no 712255. formerly named "kyndill ii". | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Acknowledgement of terms. | Erstellt am 29. Sept. 1986 Geliefert am 08. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Sterling pound and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge dated 29 sept. 1986. | |
Kurze Angaben 1968 motor tanker, single screw "kyndill ii". | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 15. Jan. 1985 Geliefert am 24. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current | |
Kurze Angaben Motor vessel named. "James royel" official number 334743. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of covenant | Erstellt am 18. März 1983 Geliefert am 24. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Further securing sterling pound 272800 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security documents. | |
Kurze Angaben The ship,the earnings of the ship and requisition compensation as defined in the deed of covenant. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 18. März 1983 Geliefert am 24. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a financial agreement and a deed of covenant both dated 18TH march 1983 | |
Kurze Angaben 64/64TH shares in the M.V. "douglas mcwilliam" registered at the port of southampton under official number 700446. ("the ship"). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 30. Dez. 1982 Geliefert am 31. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, trade & other fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat DEAN & DYBALL MARINE LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0