DT REALISATIONS (2012) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DT REALISATIONS (2012) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01644925 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
- (6512) /
Wo befindet sich DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Chancery 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DAVENHAM TRUST LIMITED | 19. März 2010 | 19. März 2010 |
| DAVENHAM TRUST COMPANY LIMITED | 18. Feb. 1991 | 18. Feb. 1991 |
| BURNS-ANDERSON TRUST COMPANY LIMITED | 21. Juni 1982 | 21. Juni 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 32 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. März 2014 | 27 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Sept. 2013 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator | 14 Seiten | 2.39B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. März 2013 | 39 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Feb. 2013 | 41 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed davenham trust LIMITED\certificate issued on 04/03/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Aug. 2012 | 46 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Apr. 2012 | 46 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 5 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 87 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 77 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 274 Deansgate Camp Street Manchester M3 4JB England* am 20. Okt. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von James Rodier Kerr-Muir als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 8 St John Street Manchester M3 4DU* am 29. Juni 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 Seiten | CERT10 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DT REALISATIONS (2012) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCONSULT LIMITED | Sekretär | 173 Chorley New Road BL1 4QZ Bolton Laurel House United Kingdom |
| 137685820001 | ||||||||||
| BURKE, Paul | Geschäftsführer | 58 Spring Gardens M2 1EW Manchester The Chancery | United Kingdom | British | 104461630001 | |||||||||
| KERR-MUIR, James Rodier | Geschäftsführer | Deansgate Camp Street M3 4JB Manchester 274 Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 163887670001 | |||||||||
| HAMLYN, John Michael | Sekretär | Stoneridge Cottage Green Lane Disley SK12 2AL Stockport Cheshire | British | 55749820002 | ||||||||||
| SMETHURST, Dawn Elizabeth | Sekretär | 5 Pheasant Walk High Legh WA16 6LU Knutsford Cheshire | British | 58471810001 | ||||||||||
| BAYES, Maurice Arthur | Geschäftsführer | 25 The Avenue SM2 7QA Sutton Surrey | British | 43642070001 | ||||||||||
| BOWLES, David | Geschäftsführer | 2 Yarra Court Gildersome Morley LS27 7LA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 120417090001 | |||||||||
| BRIERLEY, David | Geschäftsführer | 13 Strawberry Hill Drive Paget Pg 05 FOREIGN Bermuda | Canadian | 60105890001 | ||||||||||
| BROOKS, Graham Corby | Geschäftsführer | 23 Mount Wyndham Drive Hamilton Parish Cro4 Bermuda | British | 74509600001 | ||||||||||
| COATES, David Raiffe | Geschäftsführer | 8 St John Street Manchester M3 4DU | England | British | 103580860001 | |||||||||
| DAVENPORT, Colin | Geschäftsführer | 19a Tanhouse Lane Parbold WN8 7HG Wigan Lancashire | British | 52877220001 | ||||||||||
| DIGGINES, Jonathan Brett | Geschäftsführer | Rossways 32 Broad Lane WA15 0DH Hale Cheshire | British | 80119110001 | ||||||||||
| FARLEY, Henry Edward | Geschäftsführer | Sylvan Lodge Leycester Road WA16 8QR Knutsford Cheshire | British | 75054860003 | ||||||||||
| FERRETT, Richard John | Geschäftsführer | Wistowe 21 North Shore Road Hamilton Parish Fl04 Bermuda | British | 65960600001 | ||||||||||
| GOOM, Roderick John | Geschäftsführer | Cote D Azur 5 Prospero Lane FL 08 Knapton Hill Smiths Bermuda | British | 52821370003 | ||||||||||
| HAIGH, David William | Geschäftsführer | Well House Hook Heath Road GU22 0LF Woking Surrey | British | 15163170001 | ||||||||||
| HAMLYN, John Michael | Geschäftsführer | Stoneridge Cottage Green Lane Disley SK12 2AL Stockport Cheshire | British | 55749820002 | ||||||||||
| HASTED, Charles Vernon | Geschäftsführer | 2 Garth Heights Wilmslow Park North SK9 2BA Wilmslow Cheshire | England | British | 83873510001 | |||||||||
| JOHNSTON, Malcolm Carlyle Calum | Geschäftsführer | B5 3 Queens Cove Pembroke Hm 05 Bermuda | British Canadian | 74796290001 | ||||||||||
| MARSH, Steven Robert | Geschäftsführer | 156 Chester Road Hazel Grove SK7 6HE Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 21400080002 | |||||||||
| NEWTON, Paul Michael | Geschäftsführer | Over Hall Farm Flag Lane PR26 9AD Bretherton Lancashire | United Kingdom | British | 109730120001 | |||||||||
| PRETTY, Mark Andrew | Geschäftsführer | 86 Grange Road Bramhall SK7 3QB Stockport Cheshire | British | 24439960001 | ||||||||||
| SHARP, William Drummond | Geschäftsführer | Norwood 12 A Harrop Road Hale WA15 9BX Altrincham Cheshire | England | British | 2841420001 | |||||||||
| SHORE, Wayne | Geschäftsführer | 49 Chatsworth Road S17 3QG Sheffield South Yorkshire | England | British | 89240700001 | |||||||||
| TRIPPIER, David Austin, Sir | Geschäftsführer | Dowry Head Helmshore BB4 4AE Rossendale Lancashire | British | 27871400001 | ||||||||||
| WISE, Raymond | Geschäftsführer | 116 Moss Lane M33 5BH Sale Cheshire | United Kingdom | British | 70672960001 |
Hat DT REALISATIONS (2012) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. März 2009 Geliefert am 01. Apr. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other creditors (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Apr. 2002 Geliefert am 07. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become from the chargors to the lenders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 8/8A st john street t/no. GM96521, the f/h property k/a 16 longworth street t/no. LA352072 and the l/h property k/a premises on 2ND floor, 274 deansgate, manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. März 2002 Geliefert am 16. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land adjoining higher crumpsall liberal club seymour road crumpsall t/no;-GM191100. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 16. Juni 2000 Geliefert am 27. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Juni 2000 Geliefert am 26. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben The freehold land and buildings being 8/8A st john street and 16 longworth street title numbers GM96521 and LA352072 by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 16. Juni 2000 Geliefert am 26. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever of each charging company (as defined) to the chargee, as security trustee for the beneficiaries (as defined) under the facility documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Block discounting agreement | Erstellt am 14. Sept. 1999 Geliefert am 15. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben First floating charge over all the indebtedness with the full benefit of all guarantees etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Master block discounting agreement (the "block discounting agreement") | Erstellt am 21. Juli 1999 Geliefert am 05. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the block discounting agreement | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the unassigned debts relating to the equipment the subject of any agreement in existence now or hereafter. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of security and charge of sub-leases | Erstellt am 14. Jan. 1999 Geliefert am 04. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the acquisition documents (as defined) and the security documents (as defined) | |
Kurze Angaben All of the assignor's present and future right title benefit and interest together with all rights (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Block discounting agreement | Erstellt am 05. Mai 1992 Geliefert am 08. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a discounting agreement dated 05/05/92 | |
Kurze Angaben First floating charge over all of the company's right title and interest in & to the debts & assets under a block discounting agreement ( see form 395 for full details ). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DT REALISATIONS (2012) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0