PAYCHANNEL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PAYCHANNEL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01645175 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAYCHANNEL LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich PAYCHANNEL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Challenge House International Drive GL20 8UQ Tewkesbury Gloucestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAYCHANNEL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRANSACSYS APPLICATIONS LTD | 23. Mai 2003 | 23. Mai 2003 |
| G2 LIMITED. | 20. Sept. 2002 | 20. Sept. 2002 |
| TRANSACSYS APPLICATIONS LIMITED | 09. Apr. 2001 | 09. Apr. 2001 |
| GIROVEND SYSTEMS LIMITED | 21. Okt. 1997 | 21. Okt. 1997 |
| GIROVEND CASHLESS SYSTEMS (UK) LIMITED | 23. Aug. 1982 | 23. Aug. 1982 |
| COLAW ONE LIMITED | 21. Juni 1982 | 21. Juni 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAYCHANNEL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PAYCHANNEL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed transacsys applications LTD\certificate issued on 31/07/06 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAYCHANNEL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THORINGTON-JONES, Gary, Mr. | Sekretär | 29 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | British | 85541780001 | ||||||
| CLARKSON, James Robert | Geschäftsführer | 9 Westwood Close The Briars WR9 0BD Droitwich Spa Worcestershire | United Kingdom | British | 72610550001 | |||||
| THORINGTON-JONES, Gary, Mr. | Geschäftsführer | 29 Meadowvale Road Lickey End B60 1JY Bromsgrove Worcestershire | England | British | 85541780001 | |||||
| WHITELOCK, Noel Keith | Geschäftsführer | 154 Cheltenham Road WR11 2LW Evesham Worcestershire | United Kingdom | British | 14940620001 | |||||
| ALLEN, Matthew Charles | Sekretär | 75 Park Road W4 3EY London | British | 37599910001 | ||||||
| BAILEY, John | Sekretär | Stockton Grange The Village Stockton On The Forest YO3 9UW York North Yorkshire | British | 41823950002 | ||||||
| BANYARD, Alec William James | Sekretär | 17 Hampstead Gardens SS5 5HN Hockley Essex | British | 32189370001 | ||||||
| FIETH, Robin Paul | Sekretär | Timbers Pyrton OX49 5AP Watlington Oxfordshire | British | 49907850002 | ||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Sekretär | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | English | 107835250001 | ||||||
| KATZ, Peter David | Sekretär | 20 Tudor Close IG8 0LF Woodford Green Essex | British | 64682050001 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Sekretär | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | British | 116252510001 | ||||||
| PECK, Martin David | Sekretär | 30 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | British | 78149370002 | ||||||
| WELCH, David Michael Geoffrey | Sekretär | Inigo House 29 Bedford Street WC2E 9ED London | British | 43153490002 | ||||||
| CLAIR, Peter | Geschäftsführer | 4 White Hermitage Church Road Old Windsor SL4 2JX Windsor Berkshire | British | 47537030003 | ||||||
| CLARK, Ronald Thomson | Geschäftsführer | Gill House Runsell Green, Danbury CM3 4QZ Chelmsford Essex | British | 69705410001 | ||||||
| DRUDY, Carmel Ann | Geschäftsführer | 15 Cinnamon Row Battersea SW11 3TW London | British | 40928410001 | ||||||
| FIETH, Robin Paul | Geschäftsführer | Timbers Pyrton OX49 5AP Watlington Oxfordshire | England | British | 49907850002 | |||||
| GREGSON, Robin Anthony | Geschäftsführer | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||
| GREHS, Barbara | Geschäftsführer | 14 Overy House Webber Row SE1 8QX London | British | 42212470001 | ||||||
| HARRIS, Glyn | Geschäftsführer | Ty Gwyn Boverton Road CF61 1YA Llantwit Major South Glam | British | 8555610001 | ||||||
| KOBEISSI, Mario | Geschäftsführer | 67 Boardwalk Place E14 5SE London | British | 92156280001 | ||||||
| LAING, Andrew Murray | Geschäftsführer | 14 Petley Road W6 9ST London | British | 28771390001 | ||||||
| LAVERACK, Harold Thomas | Geschäftsführer | 68 The Holloway WR9 7AX Droitwich Worcestershire | British | 19389720001 | ||||||
| MADISON HAYNE, Hayne | Geschäftsführer | 100 Scenic Highway 46 Lookout Mountain Tennesse United States Of America | American | 45373130001 | ||||||
| MCGRANE, Paul Steven | Geschäftsführer | 21 Stony Lane NR10 4QS Reepham Norwich | United Kingdom | British | 51004210002 | |||||
| MCNAIR, John | Geschäftsführer | 7 Westcombe Park Road SE3 7RE London | British | 61297520001 | ||||||
| MILLS, Mark Richard | Geschäftsführer | 55 Hove Road FY8 1XH Lytham St Annes Lancashire | British | 10402540005 | ||||||
| NEUBAUER, Eirion Andrew Charles | Geschäftsführer | Flat 11 Kingsley Lodge 13 New Cavendish Street W1G 9UG London | England | British | 116252510001 | |||||
| PECK, Martin David | Geschäftsführer | 30 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | England | British | 78149370002 | |||||
| SCHOFIELD, Janet Elizabeth | Geschäftsführer | 43 Florence Road Wimbledon SW19 8TH London | British | 36356290002 | ||||||
| SMART, Richard Ernest | Geschäftsführer | Oak House,Webbs Lane Beenham RG7 5LL Reading Berkshire | British | 7970090001 | ||||||
| SMYTH, Peter Francis | Geschäftsführer | Flat 2 62 Queens Gate SW7 5JP London | Irish | 63863190002 | ||||||
| TRACE, Charles Lawrence | Geschäftsführer | Sands Lane Small Dole BN5 9YL Henfield Ashleigh House West Sussex | England | British | 129244340001 | |||||
| WILLIAMS, Richard Idwal | Geschäftsführer | Top Flat 68 Ladbroke Grove W11 2PB London | British | 40830150002 |
Hat PAYCHANNEL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage of life policy | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or the principal debtor (as defined) to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee assigned and agreed to assign to the bank:(a) the policy of assurance set out in part iv of this schedule and all moneys (including bonuses) that may become payable thereunder.(b) all sums payable to the company in connection with the policies pursuant to section 76 of the insurance companies act 1982. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h & l/h land in england and wales including (but not limited to) the property at unit 6 (formerly unit B4) progress business centre,whittle parkway,bath road,slough.t/no.bk 266697. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Sept. 1996 Geliefert am 19. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 30. Nov. 1990 Geliefert am 20. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Counter-indemnity & charge | Erstellt am 13. Mai 1988 Geliefert am 26. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (For full details see form 395 ref: M49). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0