LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED

LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01649812
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    • (7414) /
    • (7487) /

    Wo befindet sich LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kennicott House Well Lane
    Wednesfield
    WV11 1XR Wolverhampton
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LBS ACCESSORIES LIMITED16. Mai 200716. Mai 2007
    LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED24. März 198624. März 1986
    PACETRACT LIMITED09. Juli 198209. Juli 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 29. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    7 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed lbs accessories LIMITED\certificate issued on 18/12/09
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name18. Dez. 2009

    Hinweis auf Namensänderung

    CONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Allan Stennett am 10. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 06. Okt. 2009

    RES15

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten190

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2006

    7 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    11 SeitenMA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed ludstone business services limit ed\certificate issued on 16/05/07
    2 SeitenCERTNM

    Wer sind die Geschäftsführer von LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASON, Terence Victor
    Alba Marlbrook Lane
    Pattingham
    WV6 7BS Wolverhampton
    Staffordshire
    Sekretär
    Alba Marlbrook Lane
    Pattingham
    WV6 7BS Wolverhampton
    Staffordshire
    British33909210001
    STENNETT, Allan
    Well Lane
    Wednesfield
    WV11 1XR Wolverhampton
    Kennicott House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Well Lane
    Wednesfield
    WV11 1XR Wolverhampton
    Kennicott House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director2310810002
    STENNETT, Chrisitopher
    7 Orchard Road
    Onslow Village
    GU2 7QY Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Orchard Road
    Onslow Village
    GU2 7QY Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director124980170001
    STENNETT, Janet Mary
    Upper Ludstone House Upper Ludstone
    Claverley
    WV5 7DH Wolverhampton
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Upper Ludstone House Upper Ludstone
    Claverley
    WV5 7DH Wolverhampton
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director5556840001
    TAYLOR, John Raymond
    17/502 New City Garden
    23100 Changzhou
    Jiangsu
    China
    Geschäftsführer
    17/502 New City Garden
    23100 Changzhou
    Jiangsu
    China
    ChinaBritishDirector36527280004

    Hat LUDSTONE BUSINESS SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Aug. 2004
    Geliefert am 28. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Geliefert am 24. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Apr. 1994
    Geliefert am 10. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee provided that the total amount recoverable shall not exceed an amount equal to the one half share of the company in the proceeds of sale of the mortgaged property
    Kurze Angaben
    The property k/a land lying to the north west of mount pleasant bilston west midlands wolverhampton t/n WM473405. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Apr. 1994
    Geliefert am 10. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee provided that the total amount recoverable shall not exceed an amount equal to the one half share of the company in the proceeds of sale of the mortgaged property
    Kurze Angaben
    Property k/a land lying east side of beldray road bilston west midlands wolverhampton t/n WM567473. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Apr. 1994
    Geliefert am 10. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Wales PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 05. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage made between the company,A.stennett,J.M.stennett and save and prosper insurance LTD (the last three charging as trustees for allan stennett pension fund) and the bank
    Erstellt am 02. März 1992
    Geliefert am 23. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from allan stennett, janet stennett and save and prosper insurance limited trustees of alan stennett pension fund to the chargee on any account whatsoever provided that the total amount recoverable under this mortgage shall not exceed an amount equal to the one half share of trustees of allan stennett pension fund in the proceeds of sale of the mortgaged property
    Kurze Angaben
    Land lying to the north west of mount pleasant, bilston, wolverhampton, west midlands t/no. WM473405 and the proceeds ofsale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage made between the company,A.stennett,J.M.stennett,save and prosperinsurance LTD (the last three charging as trustees for allan stennett pension fund) and the bank
    Erstellt am 02. März 1992
    Geliefert am 23. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from ludstone business services limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total amount recoverable under this mortgage shall not exceed an amount equal to the one half share of ludstone business services limited of the proceeds of sale of the mortgaged property
    Kurze Angaben
    Land to the north west of mount pleasant, bilston, wolverhampton, west midlands t/no. WM473405 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Apr. 1988
    Geliefert am 26. Apr. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0