TAB WALES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTAB WALES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01656239
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TAB WALES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TAB WALES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Blaenwaun, Ffostrasol
    Llandysul
    SA44 5JT Ceredigion
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TAB WALES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THERAPEUTIC ANTIBODIES LIMITED02. Sept. 198302. Sept. 1983
    SARIA LIMITED03. Aug. 198203. Aug. 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TAB WALES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für TAB WALES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Jan. 2013

    Kapitalaufstellung am 02. Jan. 2013

    • Kapital: GBP 8,132,319
    SH01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Nov. 2012

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Peter Geoffrey Maddox als Sekretär am 15. Feb. 2012

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Lygia Jane Jones als Sekretär am 15. Feb. 2012

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von James Christie als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von James Christie als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Sekretärs für Peter Geoffrey Maddox am 31. Dez. 2010

    2 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für James Campbell Christie am 31. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Sekretärs für Peter Geoffrey Maddox am 31. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von TAB WALES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, Lygia Jane
    Blaenwaun, Ffostrasol
    Llandysul
    SA44 5JT Ceredigion
    Sekretär
    Blaenwaun, Ffostrasol
    Llandysul
    SA44 5JT Ceredigion
    166927550001
    MAKIN, Pamela Louise, Dame
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Geschäftsführer
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish111491920002
    SODERSTROM, Rolf Kristian Berndtson
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Geschäftsführer
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish123922800005
    CHARD, Timothy, Professor
    509 Mountjoy House
    EC2Y 8BP London
    Sekretär
    509 Mountjoy House
    EC2Y 8BP London
    English24354460001
    COLLIER, Paul Robert
    Llanfallteg Farm
    Llanfallteg
    SA34 0UP Whitland
    Carmarthenshire
    Sekretär
    Llanfallteg Farm
    Llanfallteg
    SA34 0UP Whitland
    Carmarthenshire
    British58105660001
    HAMBLIN, Michael Alan John William
    Lower Farm West Ginge
    Ardington
    OX12 8QR Wantage
    Oxfordshire
    Sekretär
    Lower Farm West Ginge
    Ardington
    OX12 8QR Wantage
    Oxfordshire
    British37951310002
    MADDOX, Peter Geoffrey
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    British53027030001
    VICKERS, Julie Alison
    57 White Park Close
    CW10 9GB Middlewich
    Cheshire
    Sekretär
    57 White Park Close
    CW10 9GB Middlewich
    Cheshire
    British71031050003
    BROWNE, Harry Gray, Dr
    4626 Columbia Highway
    FOREIGN Thompson Station
    Tennessee 37179
    Usa
    Geschäftsführer
    4626 Columbia Highway
    FOREIGN Thompson Station
    Tennessee 37179
    Usa
    Us31059280001
    CHARD, Timothy
    171 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Geschäftsführer
    171 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    English24354460002
    CHRISTIE, James Campbell
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish63090380001
    HEATH, Andrew John William, Dr
    Flat 2
    24 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    24 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    United KingdomBritish66554500005
    KAZIMI, Aj
    712 Overton Park
    FOREIGN Nashville
    Tennessee 37215
    Usa
    Geschäftsführer
    712 Overton Park
    FOREIGN Nashville
    Tennessee 37215
    Usa
    Us31059270001
    LANDON, John, Professor
    535 Willoughby House
    EC2Y 8BN London
    Geschäftsführer
    535 Willoughby House
    EC2Y 8BN London
    British14699440001
    REES, David Ian
    Cae Nos
    Ffostrasol
    SA44 5JT Llandysul
    Dyfed
    Geschäftsführer
    Cae Nos
    Ffostrasol
    SA44 5JT Llandysul
    Dyfed
    British59818880001
    SODEN, Christine Helen
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Geschäftsführer
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    British65904960008

    Hat TAB WALES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Sublease agreement
    Erstellt am 14. Dez. 1995
    Geliefert am 19. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Kurze Angaben
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 009 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sublease agreement
    Erstellt am 27. Okt. 1995
    Geliefert am 19. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Kurze Angaben
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 008 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 25. Okt. 1995
    Geliefert am 03. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from therapeutic antibodies inc to the chargee under the terms of a promissory note dated 24TH july 1995, an amended and restated promissory note and loan agreement both dated 25TH october 1995 and/or in connection with this supplemental debenture
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all book debts owing to the company and all stock and work in progress (including all stocks of anti sera) the property of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Equitas, L.P.
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juli 1995
    Geliefert am 04. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from therapeutic antibodies inc to the chargee under the terms of a promissory note of even date and a guarantee (as defined)
    Kurze Angaben
    Floating charge over all book debts owing to the company and all stock and work in progress. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Equitas L.P.
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Intellectual property mortgage
    Erstellt am 03. Mai 1995
    Geliefert am 23. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a secured loan agreement dated 3RD may 1995 and the mortgage as defined therein
    Kurze Angaben
    All the intellectual property including UK patent number 2271509B entitled "an venom immunesera" together with the full benefit of all rights and know-how. All trade marks and a floating charge over all rights and interests in the property,assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Welsh Development Agency(The "Agency")
    Transaktionen
    • 23. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sublease agreement
    Erstellt am 10. Apr. 1995
    Geliefert am 19. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Kurze Angaben
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease agreement and acceptance certificate no 007 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sublease agreement
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 19. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Kurze Angaben
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 006 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sublease agreement
    Erstellt am 07. Dez. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Kurze Angaben
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 005 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Sublease agreement
    Erstellt am 01. Sept. 1994
    Geliefert am 19. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Kurze Angaben
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 001 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 04. Juli 1994
    Geliefert am 11. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £7,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 97853216 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Juli 1993
    Geliefert am 09. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Intellectual property mortgage
    Erstellt am 06. Okt. 1992
    Geliefert am 13. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the welsh development agency under the terms of a secured loan agreement of even date and or this charge.
    Kurze Angaben
    All the intellectual property of the company both present and future please see doc for full details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Welsh Development Agency.
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TAB WALES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Juli 2013Aufgelöst am
    19. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    Praktiker
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0