POLARFROST SEAFOODS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePOLARFROST SEAFOODS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01659536
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von POLARFROST SEAFOODS LIMITED?

    • Großhandel mit anderen Nahrungsmitteln, einschließlich Fisch, Krebs- und Schalentieren (46380) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich POLARFROST SEAFOODS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POLARFROST SEAFOODS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für POLARFROST SEAFOODS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Juli 2021

    7 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    42 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH zum 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE am 07. Mai 2021

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 05. Aug. 2020

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Juli 2020

    LRESSP

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. März 2020

    • Kapital: GBP 2
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Ernennung von Mrs Diane Susan Walker als Direktor am 24. Sept. 2019

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Jenny Nancy Loncaster als Geschäftsführer am 25. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Busby als Geschäftsführer am 12. Sept. 2019

    1 SeitenTM01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. März 2020

    1 SeitenAA01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Wilkin Chapman Llp PO Box PO Box 16 New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE United Kingdom zum Karro Food Group Hugden Way, Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG geändert

    1 SeitenAD02

    Ernennung von Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont als Direktor am 04. Juli 2019

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 04. Juli 2019

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 016595360010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von POLARFROST SEAFOODS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Geschäftsführer
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    WALKER, Diane Susan
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Geschäftsführer
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBritish156683540001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Sekretär
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    British2785890001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Sekretär
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    WRIGHT, James Leonard
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    Sekretär
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    British714180001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Sekretär
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02249348
    75197930001
    BARFORD, Peter Mark
    The Oaks
    Main Road, Barnoldby -Le-Beck
    DN37 0AU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Oaks
    Main Road, Barnoldby -Le-Beck
    DN37 0AU Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish34719940002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandDutch166335910001
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British2785880001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandBritish177239110001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    37 Brigsley Road
    Waltham
    DN37 0JX Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    37 Brigsley Road
    Waltham
    DN37 0JX Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish31098840002
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandBritish205633180001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    REDFORD, Christopher Hugh
    11 Laburnum Avenue
    Waltham
    DN37 0JT Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    Geschäftsführer
    11 Laburnum Avenue
    Waltham
    DN37 0JT Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    British50912070001
    RILATT, Simon Jonathan
    14 South Rise
    Main Street Skidby
    HU16 5UH Cottingham
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 South Rise
    Main Street Skidby
    HU16 5UH Cottingham
    East Yorkshire
    British54544170001
    RUFFELL WARD, Brian
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British72694900001
    SOUTHWELL, Barry
    24 Melbourne Avenue
    DN33 2AP Grimsby
    South Humberside
    Geschäftsführer
    24 Melbourne Avenue
    DN33 2AP Grimsby
    South Humberside
    British36604930001
    STYCHE, Paul Robert
    29a Riby Road
    DN37 8ER Keelby
    North East Lincolnshire
    Geschäftsführer
    29a Riby Road
    DN37 8ER Keelby
    North East Lincolnshire
    British40834000001
    THOMAS, Andrew George
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    British40002910008
    THOMPSON, Michael Robert
    Riverdale
    Love Lane
    LN11 9LP Louth
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Riverdale
    Love Lane
    LN11 9LP Louth
    Lincolnshire
    British12355420001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei POLARFROST SEAFOODS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06. Apr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageLaw Of England & Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03751665
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat POLARFROST SEAFOODS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Nov. 2015
    Geliefert am 09. Nov. 2015
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Mai 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Juli 2013
    Geliefert am 25. Juli 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale, London Branch
    Transaktionen
    • 25. Juli 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Okt. 2008
    Geliefert am 01. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 19. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 2008
    Geliefert am 04. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Jan. 2013Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 19. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. März 2007
    Geliefert am 31. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale the Security Agent
    Transaktionen
    • 31. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. März 2006
    Geliefert am 25. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transaktionen
    • 25. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2005
    Geliefert am 17. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed between the company, the parent and the security agent
    Erstellt am 19. März 2002
    Geliefert am 30. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transaktionen
    • 30. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Okt. 1998
    Geliefert am 03. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to national westminster bank PLC as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Okt. 1982
    Geliefert am 04. Okt. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill & uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat POLARFROST SEAFOODS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2020Beginn der Liquidation
    13. Jan. 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praktiker
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0