POLARFROST SEAFOODS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | POLARFROST SEAFOODS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01659536 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von POLARFROST SEAFOODS LIMITED?
- Großhandel mit anderen Nahrungsmitteln, einschließlich Fisch, Krebs- und Schalentieren (46380) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich POLARFROST SEAFOODS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 St. Peters Square M2 3AE Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POLARFROST SEAFOODS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für POLARFROST SEAFOODS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Juli 2021 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 42 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Rücktritt eines Liquidators | 3 Seiten | LIQ06 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH zum 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE am 07. Mai 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW zum 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 05. Aug. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. März 2020
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mrs Diane Susan Walker als Direktor am 24. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jenny Nancy Loncaster als Geschäftsführer am 25. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Mark Busby als Geschäftsführer am 12. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2019 bis 31. März 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Wilkin Chapman Llp PO Box PO Box 16 New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE United Kingdom zum Karro Food Group Hugden Way, Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont als Direktor am 04. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 04. Juli 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 016595360010 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von POLARFROST SEAFOODS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Geschäftsführer | St. Peters Square M2 3AE Manchester 1 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| WALKER, Diane Susan | Geschäftsführer | St. Peters Square M2 3AE Manchester 1 | United Kingdom | British | 156683540001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Sekretär | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | British | 2785890001 | ||||||||||
| WILSON, Andrew George Richard | Sekretär | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | 47433990002 | ||||||||||
| WRIGHT, James Leonard | Sekretär | 32 Devonshire Avenue DN32 0BW Grimsby N.E. Lincolnshire | British | 714180001 | ||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 75197930001 | ||||||||||
| BARFORD, Peter Mark | Geschäftsführer | The Oaks Main Road, Barnoldby -Le-Beck DN37 0AU Grimsby North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 34719940002 | |||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Geschäftsführer | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Geschäftsführer | Wickham Road Grimsby DN31 3SW North East Lincolnshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| CANE, James Robert | Geschäftsführer | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | 104635350001 | |||||||||
| DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Geschäftsführer | Wickham Road Grimsby DN31 3SW North East Lincolnshire | England | Dutch | 166335910001 | |||||||||
| FLEAR, Frank Alan | Geschäftsführer | 93 High Street Waltham DN37 0PN Grimsby North East Lincolnshire | British | 2785880001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan | Geschäftsführer | Hawerby Hall DN36 5PX Hawerby Cum Beesby Lincolnshire | United Kingdom | British | 58713750002 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Geschäftsführer | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Geschäftsführer | Wickham Road Grimsby DN31 3SW North East Lincolnshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Geschäftsführer | 37 Brigsley Road Waltham DN37 0JX Grimsby North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 31098840002 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Geschäftsführer | Wickham Road Grimsby DN31 3SW North East Lincolnshire | England | British | 205633180001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Geschäftsführer | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| REDFORD, Christopher Hugh | Geschäftsführer | 11 Laburnum Avenue Waltham DN37 0JT Grimsby N.E. Lincolnshire | British | 50912070001 | ||||||||||
| RILATT, Simon Jonathan | Geschäftsführer | 14 South Rise Main Street Skidby HU16 5UH Cottingham East Yorkshire | British | 54544170001 | ||||||||||
| RUFFELL WARD, Brian | Geschäftsführer | Tudor Garth 18a Stallingborough Road Healing DN41 7QN Grimsby North East Lincolnshire | British | 72694900001 | ||||||||||
| SOUTHWELL, Barry | Geschäftsführer | 24 Melbourne Avenue DN33 2AP Grimsby South Humberside | British | 36604930001 | ||||||||||
| STYCHE, Paul Robert | Geschäftsführer | 29a Riby Road DN37 8ER Keelby North East Lincolnshire | British | 40834000001 | ||||||||||
| THOMAS, Andrew George | Geschäftsführer | 14 Mount View Woodgates Lane HU14 3JG North Ferriby East Yorkshire | British | 40002910008 | ||||||||||
| THOMPSON, Michael Robert | Geschäftsführer | Riverdale Love Lane LN11 9LP Louth Lincolnshire | British | 12355420001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei POLARFROST SEAFOODS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06. Apr. 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat POLARFROST SEAFOODS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. Nov. 2015 Geliefert am 09. Nov. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 19. Juli 2013 Geliefert am 25. Juli 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 2008 Geliefert am 01. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Sept. 2008 Geliefert am 04. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. März 2007 Geliefert am 31. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. März 2006 Geliefert am 25. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 17. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed between the company, the parent and the security agent | Erstellt am 19. März 2002 Geliefert am 30. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 25. Okt. 1998 Geliefert am 03. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to national westminster bank PLC as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Okt. 1982 Geliefert am 04. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat POLARFROST SEAFOODS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0