TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01661703 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KPMG RESTRUCTURING 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| B. P. NURSING HOMES LIMITED | 03. Nov. 1982 | 03. Nov. 1982 |
| LYNGLEBE LIMITED | 03. Sept. 1982 | 03. Sept. 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2012 | 3 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bridge House Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP am 28. Dez. 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Tetley Beazley als Geschäftsführer am 07. Dez. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser Gregory als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Steven Michael Los als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Reiter als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ellerby als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 13. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| LOS, Steven Michael | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 116895800001 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Sekretär | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 6658190001 | ||||||
| WISE, Alan | Sekretär | 15 Stanway Road B71 1RW West Bromwich West Midlands | British | 10171590001 | ||||||
| WOODHEAD, Eric | Sekretär | 23 Midgley Drive B74 2TW Sutton Coldfield West Midlands | British | 100881760001 | ||||||
| ANSTEAD, Hamilton Douglas | Geschäftsführer | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | 107751890001 | ||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| BRADSHAW, Keith George | Geschäftsführer | The Chase Nurton Hill Road WV6 7HG Wolverhampton West Midlands | England | British | 2543640001 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| EDWARDS, John Richard Wilson, Wing Commander | Geschäftsführer | Lower Mill Pontesford SY5 0UF Shrewsbury Shropshire | British | 89854180001 | ||||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||
| HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Woodhill Cross In Hand TN21 0TP Heathfield East Sussex | British | 30119220002 | ||||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr | Geschäftsführer | The Thatched House Manor Way Oxshott KT22 0HU Leatherhead Surrey | British | 63915280001 | ||||||
| PRITCHARD, Deverok | Geschäftsführer | Shelrok 14 Letter Box Lane TN13 1SN Sevenoaks Kent | British | 48678280001 | ||||||
| REID, Ronald James | Geschäftsführer | Ackleton Manor Folley Road Ackleton WV6 7JL Wolverhampton West Midlands | British | 125690600001 | ||||||
| REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||
| SMITH, Graham | Geschäftsführer | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 142125320001 | |||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| WAINWRIGHT, Gerard Bernard | Geschäftsführer | Hargrove Wall Under Heywood SY6 7DP Church Stretton Shropshire | United Kingdom | British | 48897350001 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 |
Hat TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental trust deed | Erstellt am 25. Okt. 1991 Geliefert am 13. Nov. 1991 Datum des Sicherungsinstruments 25. Okt. 1991 | Ausstehend | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 31. Mai 1991 Geliefert am 06. Juni 1991 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £15,750,000 11.8% first mortgage debenture stock of takare PLC and £9,250,000 11.8% first mortgage stock of takare PLC and all other moneys due or to become due to the chargee under the trust deed and any deed supplemental thereto | |
Kurze Angaben Freehold court house nursing home, situate at 3/5 court road, barnards green, malvern, hereford & worcs; old gates nursing home, situate at liverey branch road, fenricowles, blackburn, lancashire title no la 559298 hinley mill nursing home situate at school road, hinley, dudley, west midlands (see doc M120 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 15. Mai 1989 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £9,250,000 11.8% first mortgage debenture stock 2014 of takare PLC and all other moneys due or to become due to the charge as defined in the deed | |
Kurze Angaben "Court house" nursing home. 3/5 court road barnards green, malvern hereford & worcestershire "old gates" nursing home. Livesey branch road, feniscowles blackburn lancashire title no la 559298. "hinky mill" nursing home, school road himley dudley, west midlands.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 1989 Geliefert am 06. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a or being st. Catherine's nursing home, spring road, letchworth, hertfordshire by way of assignment of goodwill of the business if any.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1987 Geliefert am 13. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property: st. Cloud, powick, worcestershire. Together with, fixed plant machinery fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 12. Dez. 1986 Geliefert am 17. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 01. Nov. 1985 Geliefert am 12. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land k/a the court hse nursing home, court road, malvern, worcestershire. (See doc M20 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 1985 Geliefert am 29. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land k/a pendyne nursing home hastings road 26 hastings road and 15 elmstead road bexhill t/n:- sx 116796 esx 29611 and sx 145542. l/h property k/a st catherines nursing home spring road letchworth, herts.(see doc M19 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Feb. 1985 Geliefert am 06. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (1) f/h the court house nursing home, court road malvern hereford and worcester.(2) The court farm house near the junction of court road with barnards green road, malvern hereford & worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juni 1984 Geliefert am 29. Juni 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £290,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben (1) f/h the court house nursing home, court road malvern hereford and worcester.(2) The court farm house near the junction of court road with barnards green road, malvern hereford & worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1983 Geliefert am 06. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a pendyne nursing home, hastings road, bexhill and being nos. 24 and 26 hastings road, and no. 15 elmstead road, bexhill, T.nos. Sx 116796 esx 29611 sx 145542.. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1983 Geliefert am 06. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land k/a st. Catherine's nursing home, spring road, letchworth, hertfordshire.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1983 Geliefert am 06. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land k/a withyfield nursing home, green lane, farnham royal parish, beacons field, buckinghamshire T.N. bm 54160. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Okt. 1982 Geliefert am 21. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 1982 Geliefert am 27. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £170,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben 1) the court house, nursing home, court road, malvern hereford and worcestershire 2) the court farm house situate near the junction at court road with barnards green road malvern hereford and worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0