TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED

TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01661703
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    B. P. NURSING HOMES LIMITED03. Nov. 198203. Nov. 1982
    LYNGLEBE LIMITED03. Sept. 198203. Sept. 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Dez. 2012

    3 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bridge House Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP am 28. Dez. 2011

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    4 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Dez. 2011

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Tetley Beazley als Geschäftsführer am 07. Dez. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 06. Mai 2011

    • Kapital: GBP 20,200
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Fraser Gregory als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Steven Michael Los als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Simon Reiter als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Ellerby als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 13. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Sekretär
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    LOS, Steven Michael
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Geschäftsführer
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish116895800001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    WISE, Alan
    15 Stanway Road
    B71 1RW West Bromwich
    West Midlands
    Sekretär
    15 Stanway Road
    B71 1RW West Bromwich
    West Midlands
    British10171590001
    WOODHEAD, Eric
    23 Midgley Drive
    B74 2TW Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    23 Midgley Drive
    B74 2TW Sutton Coldfield
    West Midlands
    British100881760001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Geschäftsführer
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    BRADSHAW, Keith George
    The Chase Nurton Hill Road
    WV6 7HG Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Chase Nurton Hill Road
    WV6 7HG Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish2543640001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    EDWARDS, John Richard Wilson, Wing Commander
    Lower Mill
    Pontesford
    SY5 0UF Shrewsbury
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Lower Mill
    Pontesford
    SY5 0UF Shrewsbury
    Shropshire
    British89854180001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270003
    HEYWOOD, Anthony George
    Woodhill
    Cross In Hand
    TN21 0TP Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Woodhill
    Cross In Hand
    TN21 0TP Heathfield
    East Sussex
    British30119220002
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    British63915280001
    PRITCHARD, Deverok
    Shelrok 14 Letter Box Lane
    TN13 1SN Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Shelrok 14 Letter Box Lane
    TN13 1SN Sevenoaks
    Kent
    British48678280001
    REID, Ronald James
    Ackleton Manor
    Folley Road Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Ackleton Manor
    Folley Road Ackleton
    WV6 7JL Wolverhampton
    West Midlands
    British125690600001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Geschäftsführer
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Geschäftsführer
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WAINWRIGHT, Gerard Bernard
    Hargrove
    Wall Under Heywood
    SY6 7DP Church Stretton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Hargrove
    Wall Under Heywood
    SY6 7DP Church Stretton
    Shropshire
    United KingdomBritish48897350001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    Hat TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second supplemental trust deed
    Erstellt am 25. Okt. 1991
    Geliefert am 13. Nov. 1991
    Datum des Sicherungsinstruments 25. Okt. 1991
    Ausstehend
    Berechtigte Personen
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1991Registrierung einer Belastung zur Sicherung einer Serie von Schuldverschreibungen (397)
    Supplemental trust deed
    Erstellt am 31. Mai 1991
    Geliefert am 06. Juni 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £15,750,000 11.8% first mortgage debenture stock of takare PLC and £9,250,000 11.8% first mortgage stock of takare PLC and all other moneys due or to become due to the chargee under the trust deed and any deed supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Freehold court house nursing home, situate at 3/5 court road, barnards green, malvern, hereford & worcs; old gates nursing home, situate at liverey branch road, fenricowles, blackburn, lancashire title no la 559298 hinley mill nursing home situate at school road, hinley, dudley, west midlands (see doc M120 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transaktionen
    • 06. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 24. März 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Trust deed
    Erstellt am 28. Apr. 1989
    Geliefert am 15. Mai 1989
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £9,250,000 11.8% first mortgage debenture stock 2014 of takare PLC and all other moneys due or to become due to the charge as defined in the deed
    Kurze Angaben
    "Court house" nursing home. 3/5 court road barnards green, malvern hereford & worcestershire "old gates" nursing home. Livesey branch road, feniscowles blackburn lancashire title no la 559298. "hinky mill" nursing home, school road himley dudley, west midlands.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Trust Company Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    • 24. März 1993Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 1989
    Geliefert am 06. Mai 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a or being st. Catherine's nursing home, spring road, letchworth, hertfordshire by way of assignment of goodwill of the business if any.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1989Registrierung einer Belastung
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 1987
    Geliefert am 13. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property: st. Cloud, powick, worcestershire. Together with, fixed plant machinery fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    Single debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1986
    Geliefert am 17. Dez. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1986Registrierung einer Belastung
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 01. Nov. 1985
    Geliefert am 12. Nov. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land k/a the court hse nursing home, court road, malvern, worcestershire. (See doc M20 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1985
    Geliefert am 29. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land k/a pendyne nursing home hastings road 26 hastings road and 15 elmstead road bexhill t/n:- sx 116796 esx 29611 and sx 145542. l/h property k/a st catherines nursing home spring road letchworth, herts.(see doc M19 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 1985
    Geliefert am 06. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (1) f/h the court house nursing home, court road malvern hereford and worcester.(2) The court farm house near the junction of court road with barnards green road, malvern hereford & worcester.
    Berechtigte Personen
    • Mercantile Credit Company Limited.
    Transaktionen
    • 06. März 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juni 1984
    Geliefert am 29. Juni 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £290,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    (1) f/h the court house nursing home, court road malvern hereford and worcester.(2) The court farm house near the junction of court road with barnards green road, malvern hereford & worcester.
    Berechtigte Personen
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transaktionen
    • 29. Juni 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1983
    Geliefert am 06. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a pendyne nursing home, hastings road, bexhill and being nos. 24 and 26 hastings road, and no. 15 elmstead road, bexhill, T.nos. Sx 116796 esx 29611 sx 145542.. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1983
    Geliefert am 06. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land k/a st. Catherine's nursing home, spring road, letchworth, hertfordshire.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1983
    Geliefert am 06. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land k/a withyfield nursing home, green lane, farnham royal parish, beacons field, buckinghamshire T.N. bm 54160. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 18. Okt. 1982
    Geliefert am 21. Okt. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 1982
    Geliefert am 27. Okt. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £170,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Kurze Angaben
    1) the court house, nursing home, court road, malvern hereford and worcestershire 2) the court farm house situate near the junction at court road with barnards green road malvern hereford and worcester.
    Berechtigte Personen
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat TAKARE SPECIAL PROJECTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Juni 2013Aufgelöst am
    07. Dez. 2011Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0