WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01671730 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 201 Second Floor Design Centre East Chelsea Harbour SW10 0XF London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PPP BEAUMONT PLC | 21. Dez. 1988 | 21. Dez. 1988 |
BEAUMONT HEALTH CARE PLC | 27. Aug. 1987 | 27. Aug. 1987 |
GLS 26 LIMITED | 13. Okt. 1982 | 13. Okt. 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 09. Apr. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Parsons als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 32 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 33 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 25. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Ian Portal als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon Hather als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* am 13. Dez. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTAL, Ian | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | 165754850001 | |||||||
DUNCAN, David Gregor | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 97755760001 | ||||
HATHER, Jon | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | England | English | Company Secretary | 68848420006 | ||||
BOTFIELD, Adrienne Elizabeth | Sekretär | 5 Camden Place SL8 5RW Bourne End Buckinghamshire | British | 35490330001 | ||||||
CLANCY, Martin Bernard | Sekretär | 8 Henley Wood Road Earley RG6 7EE Reading Berkshire | British | 40197260001 | ||||||
HATHER, Jon | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | Company Secretary | 68848420004 | |||||
LANGFORD, Jacqueline Ann | Sekretär | 10 Mariners Mews E14 3EQ London | British | 9517840001 | ||||||
O'CONNELL, Kevin Daniel | Sekretär | 27 Stag Green Avenue AL9 5EB Hatfield Hertfordshire | English | 15336730002 | ||||||
PIPER, Maurice George | Sekretär | 8 Chestnut Lane Matfield TN12 7JL Tonbridge Kent | British | 8141120001 | ||||||
PURSE, Stephen John | Sekretär | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | British | 58759290001 | ||||||
BENN, Geoffrey Richard | Geschäftsführer | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | Managing Director | 73786580001 | ||||
CHURCHLEY, Peter Knight | Geschäftsführer | Rosevale House Woodside Lane SL4 2DW Windsor Forest Berkshire | England | British | Managing Director Senior Livin | 77173520001 | ||||
EASTERMAN, Philip Harry | Geschäftsführer | 3 Oakview Hyde Heath HP6 5SE Amersham Buckinghamshire | British | Finance Director | 63476990001 | |||||
HEYWOOD, Anthony George | Geschäftsführer | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | Director | 131288260001 | ||||
LORD, Peter Herent | Geschäftsführer | Holly Tree House 39 Grove Road HP9 1PE Beaconsfield Buckinghamshire | British | Consultant Surgeon | 2468810001 | |||||
MATTHEWS, Ian | Geschäftsführer | Ffordd Bryngwyn Gwernymynydd CH7 5JW Nr Mold The Croft Flintshire | United Kingdom | British | Accountant | 143242660001 | ||||
MATTINSON, Graham Thomas | Geschäftsführer | Crantock House 6 Stratford Drive Wootton NN4 6JT Northampton Northamptonshire | British | Managing Director | 76843330001 | |||||
MCGARTOLL, Owen Raphael | Geschäftsführer | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | Director | 116537370001 | |||||
MCNEILLY, Robert Henry, Dr | Geschäftsführer | Forge House Coleshill HP7 0LR Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British Northern Ireland | Director Of Health Services | 10813190001 | ||||
MITCHELL, Nick | Geschäftsführer | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield | Englsih | Finance Director | 92869540001 | |||||
NOAR, Stephen John | Geschäftsführer | Hornbeams Swarraton SO24 9TQ Alresford Hampshire | British | Director Of Dental Services | 64053050003 | |||||
PARSONS, Michael Dennis | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 44895330007 | ||||
PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr | Geschäftsführer | The Thatched House Manor Way Oxshott KT22 0HU Leatherhead Surrey | British | Director | 63915280001 | |||||
PROBERT, David Henry | Geschäftsführer | 4 Blakes Field Drive Barnt Green B45 8JT Birmingham | British | Director Of Companies | 1776640001 | |||||
PURSE, Stephen John | Geschäftsführer | 36 Newry Road TW1 1PL Twickenham London | England | British | Finance Director | 58759290001 | ||||
SCOTT, Iain John Gosman | Geschäftsführer | 37 Midmills Road IV2 3NZ Inverness Inverness Shire | Scotland | British | Finance Director | 40335260002 | ||||
SCOTT, Kenneth Cameron Knowles | Geschäftsführer | Weeke Hill TQ6 0JT Dartmouth Little Weeke Devon | United Kingdom | British | Legal Counsel | 86218520002 | ||||
STREET, Timothy William | Geschäftsführer | Flat 23 Park House 16 Northfields SW18 1DD London | Australian | Director | 91455710001 | |||||
TORRANCE, David Winton Watt | Geschäftsführer | Allt A'Bruaich IV4 7HX Kiltarlity Inverness-Shire | Uk | British | Group Finance Director | 5901560006 | ||||
WEIGHT, James Dominic | Geschäftsführer | 11 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | England | British | Chief Financial Officer | 73750450005 | ||||
WILSON, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 5 Court Lane Gardens Dulwich SE21 7DZ London | United Kingdom | British | Banker | 82667700001 |
Hat WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 14. Dez. 2012 Geliefert am 19. Dez. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Amendment deed | Erstellt am 27. Okt. 2006 Geliefert am 08. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company as junior creditor has undertaken that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities: in each case the junior creditor concerned shall hold the same upon trust for the security trustee and will promptly pay the same to the security trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Opco debenture accession deed | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 04. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An intercreditor and subordination agreement | Erstellt am 13. Juli 2006 Geliefert am 25. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security accession deed | Erstellt am 06. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of deposit account monies | Erstellt am 21. Nov. 1988 Geliefert am 23. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben The sum of £300,000 in an account in the name of the company an deposit with 3I group. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 21. Nov. 1988 Geliefert am 23. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Freehold premises situate at and k/a bushwood house 32 st. James' road edgbaston birmingham west midlands title no. Wm 410766 (not excluding the area shown in blue on plan 2 and which is currently under title no. Wm 439481). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 15. Sept. 1988 Geliefert am 22. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the of the compahy, present & future. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Sept. 1988 Geliefert am 22. Sept. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Herne place, london road, sunningdale, berkshire t/N. Bk 149893. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Dez. 1987 Geliefert am 16. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as the stratford beaumont new street, stratford upon avon, warwickshire title no. Wk 298723 together with all buildings & fixtures & all plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Dez. 1987 Geliefert am 16. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as the prestbury beaumont, collar house drive, prestbury, macclesfield, cheshire. Title no. Ch 261564 together with all buildings & fixtures & all plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 09. Okt. 1987 Geliefert am 21. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Bushwood house, 32 st james's road, edgbaston birmingham, west midlands. Title no. Wk 306637. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment | Erstellt am 29. Juni 1987 Geliefert am 17. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from beaumont edgbaston limited to the chargee on any account whatsoever. Under the terms of a facility letter dated 10/4/87 | |
Kurze Angaben All right title & interest in all sums standing to the crecdit of an account of company and beaumont edgbaston limited with barclays bank PLC designated "barclays de zoele wedd limited re:- beaumont edgbaston limited cash collataral account". | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge. | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a mavon house 19/21 heatherley road camberley title no:- sy 403451 together with buildings fixtures fixed plant machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge. | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises k/a dane house clinic 52 dyke road avenue brighton title no:- esx 18133. together with buildings fixtures fixed plant machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge. | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises situate in the parishes of palgrave and wortham suffolk. Totether with all buildings fixtures plant machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge. | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a cromers close nursing care centre 56 kenilworth road coventry west midlands. Title no:- wm 321229. together with all buildings fixtures plant machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of legal mortgage - f/h land & premises situate at burston in the county of norfolk together with buildings & fixtures & fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of legal mortgage:- f/h land and premises situate at roydon road, diss, in county of norfolk together with all buildings & fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental charge. | Erstellt am 02. Apr. 1987 Geliefert am 16. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of legal mortgage:- f/h land and premises at ramsey in hampshire situate at the north of winchester road, A31 & to the east of braishfield road together with all buildings & fixture including fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of deposit account moneys. | Erstellt am 31. Dez. 1986 Geliefert am 08. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Sum of £2,500,000 deposited with investors in industry group PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 01. Aug. 1986 Geliefert am 19. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of deposit account. | Erstellt am 19. Dez. 1985 Geliefert am 23. Dez. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge upon all monies presently or from time to time standing to the credit of the company's deposit account with investors in industry PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Juli 1985 Geliefert am 16. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property to the north east of filmer lane sevenoaks kent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Juli 1985 Geliefert am 16. Juli 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a redcourt 27 stanhope road croydon t/n:- sy 247994. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0