WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED

WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWESTMINSTER BEAUMONT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01671730
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 201 Second Floor Design Centre East
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PPP BEAUMONT PLC21. Dez. 198821. Dez. 1988
    BEAUMONT HEALTH CARE PLC27. Aug. 198727. Aug. 1987
    GLS 26 LIMITED13. Okt. 198213. Okt. 1982

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 09. Apr. 2014

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 0.25
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 21/01/2014
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Michael Parsons als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 32 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 33 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jon Hather am 25. März 2013

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    15 SeitenMG01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Ian Portal als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jon Hather als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Suite 201 the Chambers Chelsea Harbour London SW10 0XF* am 13. Dez. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PORTAL, Ian
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    165754850001
    DUNCAN, David Gregor
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Secretary68848420006
    BOTFIELD, Adrienne Elizabeth
    5 Camden Place
    SL8 5RW Bourne End
    Buckinghamshire
    Sekretär
    5 Camden Place
    SL8 5RW Bourne End
    Buckinghamshire
    British35490330001
    CLANCY, Martin Bernard
    8 Henley Wood Road
    Earley
    RG6 7EE Reading
    Berkshire
    Sekretär
    8 Henley Wood Road
    Earley
    RG6 7EE Reading
    Berkshire
    British40197260001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary68848420004
    LANGFORD, Jacqueline Ann
    10 Mariners Mews
    E14 3EQ London
    Sekretär
    10 Mariners Mews
    E14 3EQ London
    British9517840001
    O'CONNELL, Kevin Daniel
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    Sekretär
    27 Stag Green Avenue
    AL9 5EB Hatfield
    Hertfordshire
    English15336730002
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Sekretär
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    British58759290001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishManaging Director73786580001
    CHURCHLEY, Peter Knight
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Rosevale House
    Woodside Lane
    SL4 2DW Windsor Forest
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director Senior Livin77173520001
    EASTERMAN, Philip Harry
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    3 Oakview
    Hyde Heath
    HP6 5SE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director63476990001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Geschäftsführer
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritishDirector131288260001
    LORD, Peter Herent
    Holly Tree House
    39 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    39 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishConsultant Surgeon2468810001
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Geschäftsführer
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    United KingdomBritishAccountant143242660001
    MATTINSON, Graham Thomas
    Crantock House 6 Stratford Drive
    Wootton
    NN4 6JT Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Crantock House 6 Stratford Drive
    Wootton
    NN4 6JT Northampton
    Northamptonshire
    BritishManaging Director76843330001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishDirector116537370001
    MCNEILLY, Robert Henry, Dr
    Forge House
    Coleshill
    HP7 0LR Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Forge House
    Coleshill
    HP7 0LR Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish Northern IrelandDirector Of Health Services10813190001
    MITCHELL, Nick
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    Geschäftsführer
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    EnglsihFinance Director92869540001
    NOAR, Stephen John
    Hornbeams
    Swarraton
    SO24 9TQ Alresford
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Hornbeams
    Swarraton
    SO24 9TQ Alresford
    Hampshire
    BritishDirector Of Dental Services64053050003
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector44895330007
    PATEL, Chaitanya Bhupendra, Dr
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Thatched House
    Manor Way Oxshott
    KT22 0HU Leatherhead
    Surrey
    BritishDirector63915280001
    PROBERT, David Henry
    4 Blakes Field Drive
    Barnt Green
    B45 8JT Birmingham
    Geschäftsführer
    4 Blakes Field Drive
    Barnt Green
    B45 8JT Birmingham
    BritishDirector Of Companies1776640001
    PURSE, Stephen John
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    Geschäftsführer
    36 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    London
    EnglandBritishFinance Director58759290001
    SCOTT, Iain John Gosman
    37 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    Geschäftsführer
    37 Midmills Road
    IV2 3NZ Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritishFinance Director40335260002
    SCOTT, Kenneth Cameron Knowles
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    Geschäftsführer
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    United KingdomBritishLegal Counsel86218520002
    STREET, Timothy William
    Flat 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    Geschäftsführer
    Flat 23 Park House
    16 Northfields
    SW18 1DD London
    AustralianDirector91455710001
    TORRANCE, David Winton Watt
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    Geschäftsführer
    Allt A'Bruaich
    IV4 7HX Kiltarlity
    Inverness-Shire
    UkBritishGroup Finance Director5901560006
    WEIGHT, James Dominic
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChief Financial Officer73750450005
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Geschäftsführer
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritishBanker82667700001

    Hat WESTMINSTER BEAUMONT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2012
    Geliefert am 19. Dez. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Amendment deed
    Erstellt am 27. Okt. 2006
    Geliefert am 08. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company as junior creditor has undertaken that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities: in each case the junior creditor concerned shall hold the same upon trust for the security trustee and will promptly pay the same to the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Opco debenture accession deed
    Erstellt am 04. Aug. 2006
    Geliefert am 04. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each bridge obligor to the bridge finance parties or bridge overdraft banks (or any of them) and the opco secured obligations being all monies due or to become due from each opco obligor to the opco finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An intercreditor and subordination agreement
    Erstellt am 13. Juli 2006
    Geliefert am 25. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Subject to clause 10.2 if at any time prior to the discharge in full of the liabilities of the senior creditors, any lender or investor receives or recovers any payment or distribution of, or on account of or in relation to, any of the liabilities which is not permitted by clause 7 any amount by way of set-off in respect of any of the liabilities owed to them which does not give effect to a payment permitted by clause 7. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 25. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security accession deed
    Erstellt am 06. Dez. 2004
    Geliefert am 17. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of deposit account monies
    Erstellt am 21. Nov. 1988
    Geliefert am 23. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    The sum of £300,000 in an account in the name of the company an deposit with 3I group.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 1988
    Geliefert am 23. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Freehold premises situate at and k/a bushwood house 32 st. James' road edgbaston birmingham west midlands title no. Wm 410766 (not excluding the area shown in blue on plan 2 and which is currently under title no. Wm 439481).
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    Floating charge
    Erstellt am 15. Sept. 1988
    Geliefert am 22. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the of the compahy, present & future. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 15. Sept. 1988
    Geliefert am 22. Sept. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Herne place, london road, sunningdale, berkshire t/N. Bk 149893.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1987
    Geliefert am 16. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as the stratford beaumont new street, stratford upon avon, warwickshire title no. Wk 298723 together with all buildings & fixtures & all plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1987
    Geliefert am 16. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as the prestbury beaumont, collar house drive, prestbury, macclesfield, cheshire. Title no. Ch 261564 together with all buildings & fixtures & all plant & machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 1987
    Geliefert am 21. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bushwood house, 32 st james's road, edgbaston birmingham, west midlands. Title no. Wk 306637.
    Berechtigte Personen
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Assignment
    Erstellt am 29. Juni 1987
    Geliefert am 17. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from beaumont edgbaston limited to the chargee on any account whatsoever. Under the terms of a facility letter dated 10/4/87
    Kurze Angaben
    All right title & interest in all sums standing to the crecdit of an account of company and beaumont edgbaston limited with barclays bank PLC designated "barclays de zoele wedd limited re:- beaumont edgbaston limited cash collataral account".
    Berechtigte Personen
    • Barclays De Zoete Wedd Limited
    Transaktionen
    • 17. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge.
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a mavon house 19/21 heatherley road camberley title no:- sy 403451 together with buildings fixtures fixed plant machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge.
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a dane house clinic 52 dyke road avenue brighton title no:- esx 18133. together with buildings fixtures fixed plant machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge.
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises situate in the parishes of palgrave and wortham suffolk. Totether with all buildings fixtures plant machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge.
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a cromers close nursing care centre 56 kenilworth road coventry west midlands. Title no:- wm 321229. together with all buildings fixtures plant machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of legal mortgage - f/h land & premises situate at burston in the county of norfolk together with buildings & fixtures & fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Indsutry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of legal mortgage:- f/h land and premises situate at roydon road, diss, in county of norfolk together with all buildings & fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge.
    Erstellt am 02. Apr. 1987
    Geliefert am 16. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of legal mortgage:- f/h land and premises at ramsey in hampshire situate at the north of winchester road, A31 & to the east of braishfield road together with all buildings & fixture including fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    Assignment of deposit account moneys.
    Erstellt am 31. Dez. 1986
    Geliefert am 08. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sum of £2,500,000 deposited with investors in industry group PLC.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 01. Aug. 1986
    Geliefert am 19. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC.
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    Assignment of deposit account.
    Erstellt am 19. Dez. 1985
    Geliefert am 23. Dez. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed charge upon all monies presently or from time to time standing to the credit of the company's deposit account with investors in industry PLC.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juli 1985
    Geliefert am 16. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property to the north east of filmer lane sevenoaks kent.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juli 1985
    Geliefert am 16. Juli 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a redcourt 27 stanhope road croydon t/n:- sy 247994.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1985Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0