SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01674987 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
- Reisebüroaktivitäten (79110) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O INTERPATH LTD 10th Floor One Marsden Street M2 1HW Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DUNDON LIMITED | 01. Nov. 1982 | 01. Nov. 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 27 Seiten | AM23 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 27 Seiten | AM10 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE zum 10th Floor One Marsden Street Manchester M2 1HW am 21. März 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 25 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters | 5 Seiten | AM11 | ||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 5 Seiten | AM16 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM04 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 3 Seiten | AM06 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 25 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt | 29 Seiten | AM16 | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz- oder zusätzlichen Verwalters | 3 Seiten | AM11 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 23 Seiten | AM10 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 25 Seiten | AM10 | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 33 Seiten | AM10 | ||
Ernennung von Mr Hugo Charles Kimber als Direktor am 02. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr John Daniel Mclaughlin als Direktor am 02. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Daniel Mclaughlin als Geschäftsführer am 02. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Hugo Charles Kimber als Geschäftsführer am 02. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||
Vorschlag des Verwalters | 56 Seiten | AM03 | ||
Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA | 19 Seiten | AM02 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom . Eboracum Way Heworth Green York Yorkshire YO31 7RE zum 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE am 21. Aug. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 3 Seiten | AM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERKAR, Ajay Ajit Peter | Geschäftsführer | One Marsden Street M2 1HW Manchester 10th Floor | United Kingdom | Indian | Company Director | 171005990001 | ||||
KIMBER, Hugo Charles | Geschäftsführer | St. Katharines Savernake SN8 3BG Marlborough St. Katharines Lodge England | England | British | Director | 113847000002 | ||||
MCLAUGHLIN, John Daniel | Geschäftsführer | Brookfield Drive Timperley WA15 6QR Altrincham 22 England | United Kingdom | British | Director | 230948990001 | ||||
BADDELEY, Robert Gregory | Sekretär | 2 Devisdale Grange Groby Road Bowdon WA14 2BY Altrincham Cheshire | British | Vd | 28024220004 | |||||
CULLEN, Dominique | Sekretär | Eboracum Way Heworth Green YO31 7RE York . Yorkshire | 195246800001 | |||||||
MAY, Timothy William | Sekretär | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | 192247070001 | |||||||
MICHEL, Carl Heinrich | Sekretär | 2 College Place Hortensia Road SW10 0QZ London | British | Director | 107791560001 | |||||
WILLIAMSON, Alexandra Dilys | Sekretär | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | British | 100325220002 | ||||||
WRAY, Mark Christopher | Sekretär | 32 Hillcrest Avenue Nether Poppleton YO2 6LD York | British | 25762230002 | ||||||
ALLAN, Leslie Stewart | Geschäftsführer | 78 Honor Oak Road SE23 3RR London | British | Company Director | 1704690001 | |||||
ANDERSON, Ian David | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 163172340002 | ||||
ATKINS, Jane Louise | Geschäftsführer | Eboracum Way Heworth Green YO31 7RE York . Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 207125210001 | ||||
ATKINSON, Richard Westaway | Geschäftsführer | Smithy Lane Farm Rainow SK10 5UP Macclesfield Cheshire | England | British | Director | 111861370001 | ||||
BADDELEY, Robert Gregory | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | Great Britain | British | Company Director | 28024220020 | ||||
BALI, Navneet | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 83088120002 | ||||
BRIGHT, Neil Irvine | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 180993450001 | ||||
CREW, James Robert | Geschäftsführer | 123 Hale Road Hale WA15 9HQ Altrincham Cheshire | British | Director | 15842470001 | |||||
CUST, Nicholas Pury | Geschäftsführer | Crookhill The Village Skelton YO3 6XY York | United Kingdom | British | Joint Managing Director | 159977730001 | ||||
DAVIES, Martin William Oliver | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 98399000002 | ||||
FENNEMORE, Roger Arnold | Geschäftsführer | 25 Chapel Street Woburn Sands MK17 8PG Milton Keynes Buckinghamshire | British | Company Director | 9399600002 | |||||
FERRIN, Eamonn | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire | United Kingdom | Irish | Company Director | 146776900001 | ||||
GOENKA, Abhishek | Geschäftsführer | Eboracum Way Heworth Green YO31 7RE York . Yorkshire | United Kingdom | Indian | General Manager | 192234860001 | ||||
HOPE, Stuart Malcolm Ronald | Geschäftsführer | 8 Nesbitt Square Coxwell Road SE19 3AB London | British | Executive Director | 49358260001 | |||||
JARVIS, Susan | Geschäftsführer | Eboracum Way Heworth Green YO31 7RE York . Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 199100680002 | ||||
JONES, Raymond Anthony Patrick | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 60728450001 | ||||
KIMBER, Hugo Charles | Geschäftsführer | St. Peters Square M2 3AE Manchester 1 | England | British | Executive Chairman | 113847000002 | ||||
LEPPARD, Matin Neal | Geschäftsführer | Parkfield House Parkfield Road WA16 8NP Knutsford Cheshire | British | Company Director | 44209650001 | |||||
MAY, Timothy William | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | England | British | Treasurer | 27408660003 | ||||
MCLAUGHLIN, John Daniel | Geschäftsführer | 30 Millbank SW1P 4DU London 3rd Floor, C/O Holidaybreak Limited Uk United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 230948990001 | ||||
MENON, Ajit Paramparambath | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | United Kingdom | British | Company Director | 170912720001 | ||||
MICHEL, Carl Heinrich | Geschäftsführer | 2 College Place Hortensia Road SW10 0QZ London | England | British | Director | 107791560001 | ||||
MOUNSER, Ian Peter | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tour Operator | 50419570001 | ||||
NEYLON, Darren Lee | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | England | English | Company Director | 69978820001 | ||||
REGAN, Frank | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Tour Operator | 35768770001 | ||||
RICHARDS, Patrick Rory | Geschäftsführer | Greenbank Lane CW8 1HW Northwich Hartford Manor Cheshire England | England | British | Company Director | 135751860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superbreak Mini Holidays Group Limited | 06. Apr. 2016 | Heworth Green YO31 7RE York Eboracum Way United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 22. Feb. 2019 Geliefert am 26. Feb. 2019 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2018 Geliefert am 05. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Registered trade mark with tm number UK00002143013; registered trade mark with tm number UK00002372700; registered trade mark with tm number UK00001382488; registered trade mark with tm number UK00001525779; and registered trade mark with tm number UK00002000435. For more information please see schedule 1 of the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2018 Geliefert am 05. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung N/A. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 04. Sept. 2014 Geliefert am 15. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 04. Sept. 2014 Geliefert am 15. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Dutch law notarial deed of pledge of shares | Erstellt am 29. Juni 2012 Geliefert am 13. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Pledge and pledges as a disclosed right of pledge to the facility agent all its shares and share rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
English law security agreement | Erstellt am 29. Juni 2012 Geliefert am 13. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of pledge of shares | Erstellt am 09. Mai 2008 Geliefert am 19. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All shares and share rights including any dividend. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 09. Mai 2008 Geliefert am 16. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Hartford manor hartford northwich t/no CH424893. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 28. Sept. 2002 Geliefert am 02. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits credited to account numbered 45992614 and any deposit or account of any other currency description or designation. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Aug. 2000 Geliefert am 16. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to the debenture dated 3RD february 1995 | Erstellt am 09. Feb. 1998 Geliefert am 11. Feb. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities at the date of the supplemental deed or thereafter due owing or incurred by the company to national westminster bank PLC (the "security trustee") and to the beneficiaries (as defined) or any of them (whether under the facility agreements,and the facility documents as defined or otherwise) and by guarantee the obligations of each other company and any other subsidiary of the parent (the guaranteed obligations) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Juli 1995 Geliefert am 14. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether under any of the facility agreements, the facility documents (as defined therein) or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 01. Juli 1992 Geliefert am 06. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee and debenture dated 14/6/90 | |
Kurze Angaben L/H property k/a lower ground floor of 297/305 grays inn road london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juni 1990 Geliefert am 29. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or antfresh limited under the terms of the charge to the chargee. | |
Kurze Angaben (See doc M248 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Jan. 1985 Geliefert am 23. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see doc M15.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Letter of charge | Erstellt am 01. Juli 1983 Geliefert am 21. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re: dunn miller associates LTD. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0