PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01676516 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PUNCH RETAIL (MANAGED HOLDINGS) LIMITED | 05. Juni 2000 | 05. Juni 2000 |
| BOSTON DINER LIMITED(THE) | 17. Jan. 1983 | 17. Jan. 1983 |
| CHIEFBADGE LIMITED | 09. Nov. 1982 | 09. Nov. 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. März 2021
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 86 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Forde als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 79 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Michael Paterson als Direktor am 23. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David James Tannahill als Geschäftsführer am 24. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 016765160005 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 24. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Punch Taverns (Fh) Limited as a person with significant control on 04. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Geschäftsführer | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191628760001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Sekretär | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175489270001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161798500001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Geschäftsführer | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FORDE, David | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| JONAS, Marc Nicholas | Geschäftsführer | 48 Oxford Gardens W10 5UN London | United Kingdom | British | 55841850003 | |||||
| JONES, Bruce Abbott | Geschäftsführer | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | 29595900002 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Geschäftsführer | 31 Rosehill Road SW18 2NY London | British | 47793260004 | ||||||
| KEMP, Deborah Jane | Geschäftsführer | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MCINTOSH, William Alan | Geschäftsführer | 7 Earls Terrace Kensington W8 6LP London | British | 46361590002 | ||||||
| OGINSKY, Kenneth Arnold | Geschäftsführer | 41 Pinfold Hill WS14 0JN Shenstone Staffordshire | British | 39198500001 | ||||||
| OSMOND, Hugh | Geschäftsführer | 10 Wellington Road NW8 9SP London | British | 6209210002 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| RIKLIN, Cornel Carl | Geschäftsführer | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | 78412270001 | |||||
| TANNAHILL, David James | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Geschäftsführer | Charlton Manor Ashley Road Charlton Kings GL52 6NS Cheltenham Gloucestershire | Gb-Eng | British | 81928120001 | |||||
| WHITEHEAD, Gordon William George | Geschäftsführer | Rosedale 24 Jacks Lane ST14 8LW Marchington Staffordshire | British | 13507460001 | ||||||
| WILKINSON, Anthony Eric | Geschäftsführer | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | 4656080002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29. Aug. 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Punch Taverns (Fh) Limited | 06. Apr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 08. Okt. 2014 Geliefert am 15. Okt. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental deed of charge | Erstellt am 03. Nov. 2003 Geliefert am 20. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third supplemental pr deed of charge | Erstellt am 15. Mai 2003 Geliefert am 02. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the pr secured parties)or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title benefit and interest present and future in to and under the pr (af) l subordinated loan and the framework agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 22. Apr. 2002 Geliefert am 08. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed 0F charge | Erstellt am 28. Juni 2000 Geliefert am 15. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties, or any other guarantor, under or in respect the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction document (as defined therein) | |
Kurze Angaben All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0