QA LEARNING SERVICES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | QA LEARNING SERVICES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01679488 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QA LEARNING SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Deloitte Llp 1 City Square LS1 2AL Leeds |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
QA LIMITED | 07. Sept. 2006 | 07. Sept. 2006 |
QA PLC | 30. Apr. 2001 | 30. Apr. 2001 |
SKILLSGROUP PLC | 09. Mai 1997 | 09. Mai 1997 |
P & P PUBLIC LIMITED COMPANY | 31. Jan. 1988 | 31. Jan. 1988 |
P & P MICRO DISTRIBUTORS PUBLIC LIMITED COMPANY | 18. Nov. 1982 | 18. Nov. 1982 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Juni 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Rath House 55-65 Uxbridge Road Slough Berkshire SL1 1SG zum Deloitte Llp 1 City Square Leeds LS1 2AL am 30. Okt. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 22. Aug. 2019
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ernennung von Paul Geddes als Direktor am 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Notification of Seckloe 208 Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 4 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||||||
Cessation of Qa-Iq Group Limited as a person with significant control on 09. Aug. 2019 | 3 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Robert George Macpherson als Geschäftsführer am 02. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Aug. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Paul Johnson als Sekretär am 25. Mai 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNNICLES, Nathan Giles | Sekretär | 55-65 Uxbridge Road SL1 1SG Slough Rath House Berkshire United Kingdom | 246765550001 | |||||||
GEDDES, Paul Robert | Geschäftsführer | SL1 1SG Slough Rath House, 55-65 Uxbridge Road Berkshire United Kingdom | England | British | None | 262110530001 | ||||
RUNNICLES, Nathan Giles | Geschäftsführer | 55-65 Uxbridge Road SL1 1SG Slough Rath House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 246765540001 | ||||
ATKIN, John Duncan | Sekretär | 20 Hallside Park WA16 8NQ Knutsford Cheshire | British | 4769830001 | ||||||
BIRCHALL, Michael John | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | British | 56115530002 | ||||||
GIBSON, Colin John | Sekretär | 4 Fairhaven Close Tytherington SK10 2QG Macclesfield Cheshire | British | Finance Director | 72748350001 | |||||
GIBSON, Colin John | Sekretär | 4 Fairhaven Close Tytherington SK10 2QG Macclesfield Cheshire | British | Company Director | 72748350001 | |||||
HYAMS, Mitchell Spencer | Sekretär | Pipers Barn 55 Copperkins Lane HP6 5RA Amersham Buckinghamshire | British | Director | 13800580002 | |||||
JOHNSON, Ian Paul | Sekretär | 55-65 Uxbridge Road SL1 1SG Slough Rath House Berkshire England | British | Company Director | 136279590001 | |||||
LUMB, Tony | Sekretär | 1 The Corner House Aimson Road West Timperley WA15 7XP Altrincham Cheshire | British | Accountant | 110543530001 | |||||
MCRITCHIE, Ruth Elizabeth | Sekretär | 9 Churchfarm Close BS37 5BZ Yate South Gloucestershire | British | Accountant | 101309030001 | |||||
SAVAGE, Mark Anthony William | Sekretär | 3 Lancaster Court Well Place GL50 2PJ Cheltenham | British | 81345070002 | ||||||
TRAINER, Martin John | Sekretär | 6 Stone Pine Road MK43 8GG Bromham Bedfordshire | British | Chartered Accountant | 124180840001 | |||||
ATKIN, John Duncan | Geschäftsführer | 20 Hallside Park WA16 8NQ Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | Group Finance Director | 4769830001 | ||||
BEAUMONT, John Richard | Geschäftsführer | The Manor House 85 High Street RH16 2HN Lindfield Sussex | British | Director | 92701330001 | |||||
BURGESS, Keith, Dr | Geschäftsführer | Hengrove The Chivery HP23 6LE Tring Hertfordshire | British | Director | 73570840001 | |||||
BURNHAM, Robert | Geschäftsführer | Fairfield Brook Lane SK9 7QG Alderley Edge Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 50665730002 | ||||
CARNWATH, Alison Jane, Dame | Geschäftsführer | The Old Dairy Sidbury EX10 0QR Sidmouth Devon | England | British | Director | 73581270001 | ||||
EATON, Wilfred Christopher, Dr | Geschäftsführer | Ladybrook House Thame Road OX10 7DA Warborough Oxon | United Kingdom | British | Company Director | 21420730001 | ||||
FISHER, Anthony Frederick | Geschäftsführer | Dunally House Walton Lane TW17 8LQ Shepperton Middlesex | British | Company Director | 8142980002 | |||||
FISHER, Peter | Geschäftsführer | Woodcroft 86 Whalley Road Wilpshire BB1 9LJ Blackburn | British | Company Director | 62613580001 | |||||
GIBSON, Colin John | Geschäftsführer | 4 Fairhaven Close Tytherington SK10 2QG Macclesfield Cheshire | England | British | Director | 72748350001 | ||||
GRANT, Charles | Geschäftsführer | New Dairy House Farm Batherton Lane, Batherton CW5 7QH Nantwich Cheshire | British | Director | 67855570001 | |||||
HOFMANN, Claes | Geschäftsführer | Sjovillans Gard S-179 75 Ska Sweden | Swedish | Director | 58754550001 | |||||
HOUGH, Robert Eric | Geschäftsführer | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | Director | 38776360001 | ||||
HUBEAUX, Christian | Geschäftsführer | 3 Rue Giovanni Gambini FOREIGN 1206 Geneva Switzerland | French | Company Director | 11215290001 | |||||
HUDD, David Leslie | Geschäftsführer | 97 Gunterstone Road W14 9BT London | England | British | Director | 26032950002 | ||||
HYAMS, Mitchell Spencer | Geschäftsführer | Pipers Barn 55 Copperkins Lane HP6 5RA Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 13800580002 | ||||
INCE, David Leslie | Geschäftsführer | 20 Clarence Road SL4 5AF Windsor Berkshire | British | Director | 67855650002 | |||||
JOHNSON, Ian Paul | Geschäftsführer | 55-65 Uxbridge Road SL1 1SG Slough Rath House Berkshire England | United Kingdom | British | Company Director | 136279590001 | ||||
KAUFFMAN, John | Geschäftsführer | The Grange Fryth Finchampstead RG40 3RN Wokingham Berkshire | British | Managing Director | 113989000001 | |||||
LIVESEY, Philip Grimshaw | Geschäftsführer | 15 Leycester Road WA16 8QR Knutsford Cheshire | British | Company Director | 50114010002 | |||||
MACPHERSON, William Robert George | Geschäftsführer | 55-65 Uxbridge Road SL1 1SG Slough Rath House Berkshire England | England | British | Company Director | 132097710001 | ||||
MARTIN, Christian John | Geschäftsführer | Kingswood House Tag Lane Wargrave RG10 9ST Reading Berkshire | England | British | Chairman | 113992220001 | ||||
MCGOUN, Michael Frederick | Geschäftsführer | The Old Rectory Church Lane Mobberley WA16 7RD Knutsford Cheshire | England | British | Company Director | 8300340001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seckloe 208 Limited | 09. Aug. 2019 | Uxbridge Road SL1 1SG Slough Rath House 55-65 Berkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Qa-Iq Group Limited | 23. Juni 2017 | 55-65 Uxbridge Rooad SL1 1SG Slough Rath House Berkshire United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für QA LEARNING SERVICES LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
30. Mai 2017 | 23. Juni 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat QA LEARNING SERVICES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 27. Sept. 2006 Geliefert am 28. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Juli 2006 Geliefert am 27. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 20. März 2003 Geliefert am 02. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 630174466 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Okt. 2002 Geliefert am 22. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at st crispin way hurstwood enterprises park haslingden lancashire rossendale t/n LA761231. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Okt. 2002 Geliefert am 22. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 08. Juli 1987 Geliefert am 24. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 08. Juli 1987 Geliefert am 24. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 gleneagle road and 5 station approach streatham title no sgl 296424 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 08. Juli 1987 Geliefert am 24. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land and property situate on the south side of dale street bilston wolverhampton title no sf 112396 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 08. Juli 1987 Geliefert am 24. Juli 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 1 carrs industrial estate, haslingden, rossendale, lancs. Title no. La 506843 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. März 1985 Geliefert am 22. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 1 gleneagle road and 5 station approach streatham london sgl 296424. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 09. Jan. 1985 Geliefert am 16. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and property situate on the south side of dale street bilston wolverhampton west midlands sf 112396. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Nov. 1984 Geliefert am 15. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land forming part of the property comprised in title no la 494564. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 21. Feb. 1984 Geliefert am 27. Feb. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat QA LEARNING SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0